PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED

PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàPORTFOLIO STOKE 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04465903
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One
    Vine Street
    W1J 0AH London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HERON STOKE INVESTMENTS (NO.4) LIMITED20 giu 200220 giu 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    5 pagineDS01

    Cessazione della carica di David John George Royds come amministratore in data 08 ago 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 lug 2012

    Stato del capitale al 02 lug 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Robert John Hugo Randall il 01 gen 2012

    2 pagineCH01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2010

    4 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John George Royds il 01 giu 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John George Royds il 01 gen 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Matrix Registrars Limited il 01 gen 2011

    2 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Blake il 01 gen 2011

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Hany Tirta come segretario

    1 pagineTM02

    Memorandum e Statuto

    7 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Agreement 10/08/2009
    RES13

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David John George Royds il 22 giu 2010

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 20 giu 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Hanny Tirta il 08 giu 2010

    1 pagineCH03

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 ago 2010 al 31 dic 2010

    1 pagineAA01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 ago 2009

    4 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Hanny Tirta il 06 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATRIX REGISTRARS LIMITED
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    England
    Segretario
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5020115
    101009980002
    BLAKE, Ian David
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    Amministratore
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    EnglandBritish91275400001
    RANDALL, Robert John Hugo
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    Amministratore
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    United KingdomBritish20859810002
    BRITTAIN, Robert Anthony
    51 Narcissus Road
    West Hampstead
    NW6 1TL London
    Segretario
    51 Narcissus Road
    West Hampstead
    NW6 1TL London
    British31753460002
    TIRTA, Hany
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    Segretario
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    British142151860001
    ZELTSER, Lionel Harvey
    59 Michleham Down
    Woodside Park
    N12 7JJ London
    Segretario
    59 Michleham Down
    Woodside Park
    N12 7JJ London
    British82318190001
    MATRIX SECURITIES LIMITED
    Gossard House
    7-8 Savile Row
    W1S 3PE London
    Segretario
    Gossard House
    7-8 Savile Row
    W1S 3PE London
    60697420001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023580001
    GOLDMAN, Alan Irving
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    Amministratore
    118 Stanmore Hill
    HA7 3BY Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish8958700001
    RONSON, Gerald Maurice
    Carrington Chase
    54 Winnington Road
    N2 0TY London
    Amministratore
    Carrington Chase
    54 Winnington Road
    N2 0TY London
    United KingdomBritish33068600001
    ROYDS, David John George
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    Amministratore
    Vine Street
    W1J 0AH London
    One
    United Kingdom
    EnglandBritish141447410004
    ZELTSER, Lionel Harvey
    59 Michleham Down
    Woodside Park
    N12 7JJ London
    Amministratore
    59 Michleham Down
    Woodside Park
    N12 7JJ London
    United KingdomBritish82318190001
    SDG REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023570001

    PORTFOLIO STOKE 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 11 ago 2009
    Consegnato il 19 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the borrower or any obligor to the chargee and the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (As Agent and Security Trustee for Itself and Each of the Secured Parties)
    Transazioni
    • 19 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 ott 2004
    Consegnato il 14 ott 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All interst in the property with short title "stoke", all present and future l/h and f/h property in england and wales, plant and machinery, stocks shares and other securities, licences, insurances, patents, interest in any pension fund, goodwill & uncalled capital, book and other debts, bank accounts, leases and agreements, rental income floating charge all assets situated outwith scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 14 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 lug 2004
    Consegnato il 05 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security trustee and each of the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Basing view basingstoke t/no HP440073, bourne house beckenham t/no SGL553814, marsh leys bedford t/no BD225068 (for further details of property charged please see schedule to form 395) fixed & floating charge over all property & assets present & future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 05 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 16 gen 2003
    Consegnato il 28 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as heron stoke investments (no 4) limited to the chargee and each of the other finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transazioni
    • 28 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Security agreement
    Creato il 29 ago 2002
    Consegnato il 06 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H property land and buildings on the north west side of etruria road being site 1A festival park hanley stoke-on-trent t/n SF457290. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London (As Agent and Trustee for the Finance Parties)
    Transazioni
    • 06 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 gen 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0