SUN CP MIDCO LIMITED

SUN CP MIDCO LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSUN CP MIDCO LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04467104
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SUN CP MIDCO LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova SUN CP MIDCO LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    One Edison Rise, New Ollerton
    Newark
    NG22 9DP Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SUN CP MIDCO LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VELVETCLOSE LIMITED21 giu 200221 giu 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di SUN CP MIDCO LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al23 apr 2015

    Quali sono le ultime deposizioni per SUN CP MIDCO LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    6 pagine4.71

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    5 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 13 apr 2016

    LRESSP

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 23 mar 2016

    • Capitale: GBP 2.00
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Credit to prof & loss acct 22/03/2016
    RES13

    Conto per una società dormiente redatto al 23 apr 2015

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 giu 2015

    Stato del capitale al 25 giu 2015

    • Capitale: GBP 51,751,045
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Inglett il 01 set 2014

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 24 apr 2014

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 giu 2014

    Stato del capitale al 23 giu 2014

    • Capitale: GBP 51,751,045
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 25 apr 2013

    6 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 21 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Peter Dalby il 17 apr 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Martin Peter Dalby il 17 apr 2013

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 26 apr 2012

    6 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di SUN CP MIDCO LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SINGH-DEHAL, Rajbinder
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Segretario
    Knighton Rise
    LE2 2RE Oadby
    6
    Leicestershire
    United Kingdom
    Other138962680001
    DALBY, Martin Peter
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    Amministratore
    The Old Granary, Went Farm
    Main Street, Womersley
    DN6 9BQ Doncaster
    South Yorkshire
    United KingdomBritishDirector83381250004
    INGLETT, Paul
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    One Edison Rise
    Nottinghamshire
    United KingdomBritishDirector81617110003
    BRADSHAW, Andrew Philip
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    Segretario
    The Chapel House
    Haseley Road
    OX44 7PP Little Milton
    Oxfordshire
    BritishDirector114356940001
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Segretario
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    British50060390001
    GRAHAM, Annabel Susan
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    Segretario
    9 Manor Mount
    SE23 3PY London
    British108637650001
    PARKER, Timothy Hugh
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    Segretario
    Kirton Road
    Egmanton
    NG2 0HF Newark
    Twitchell Barn
    Nottinghamshire
    BritishChartered Secretary138694570001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Segretario
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United StatesDirector107030970001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BARATTA, Joseph Patrick
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    Amministratore
    One Edison Rise
    New Ollerton
    NG22 9DP Newark
    Nottinghamshire
    OtherDirector94259330004
    CASTLEDINE, Trevor Vaughan
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    Amministratore
    22 Woodhayes Road
    Wimbledon
    SW19 4RF London
    BritishChartered Accountant98778780002
    EIGHTEEN, Stephen Brian
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    Amministratore
    Flat 56 Cinnabar Wharf Central
    24 Wapping High Street
    E1W 1NQ London
    United KingdomBritishBanker76313640003
    FRANCE, Malcolm Ronald
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    Amministratore
    34 Tybenham Road
    SW19 3LA London
    United KingdomBritishDirector50060390001
    HAWKES, Edward Jonathan Cameron
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    Amministratore
    143 Taybridge Street
    SW11 5PY London
    United KingdomBritishDirector93239900002
    JONAS, Marc Nicholas
    48 Oxford Gardens
    W10 5UN London
    Amministratore
    48 Oxford Gardens
    W10 5UN London
    United KingdomBritishCorporate Financier55841850003
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MCINTOSH, William Alan
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    Amministratore
    7 Earls Terrace
    Kensington
    W8 6LP London
    BritishDirector46361590002
    MOY, Neal St John
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    Amministratore
    1 Highberry
    ME19 5QT Leybourne
    Kent
    BritishBank Employee98781970001
    PIKE, Chad Rustan
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    Amministratore
    25 Burnsall Street
    SW3 3SR London
    United KingdomBritishDirector87606860002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SPENCER CHURCHILL, Edward Albert Charles, Lord
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    Amministratore
    1 Shepherds Place
    Upper Brook Street
    W1K 6ED London
    EnglandBritishDirector54889660001
    STOLL, Peter Huston
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    Amministratore
    Flat 5 20 Earls Court Square
    SW5 9DN London
    United StatesDirector107030970001
    WILSON, Christopher
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    Amministratore
    Ilex Wood
    23 Clare Hill
    KT10 9NB Esher
    Surrey
    BritishBanker103272700001

    SUN CP MIDCO LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Borrower deed of charge
    Creato il 28 feb 2012
    Consegnato il 20 mar 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to any borrower secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please see form MG01 fixed and floating charge over all property and assets present and future, including shares, insurances, goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Corporate Trustee Company (UK) Limited (the Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 20 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Securitisation floating charge debenture
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge all present and future assets property and undertaking (save for any assets situate in jersey). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intercreditor deed
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 05 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    If an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any part of the secured debt or unsecured debt or any secured creditor or un secured creditor receives all or any amount in cash or in kind of the secured debt or unsecured debt as applicable. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 05 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A security over shares deed
    Creato il 19 giu 2007
    Consegnato il 04 lug 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the tax covenant benficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The charged portfolio meaning in relation to the company its charged shares and related assets. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited (The Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 04 lug 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Intercreditor deed
    Creato il 14 dic 2006
    Consegnato il 28 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company has undertaken to the instructing agent that if an obligor makes any payment in cash or in kind on account of or for the purchase or other acquisition of all or any party of the unsecured debt; or the company receives all or any amount in cash or in kind of the unsecured debt, subject to the intercreditor deed by way of payment repayment prepayment setoff netting or in any other manner or on account of the enforcement of any security document or payment under any guarantee for any of the secured debt, in each case the company shall hold the same on trust for the instructing agent and promptly pay the same and promptly pay an amount equal to that amount so discharged,. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited as Security Trustee for the Secured Creditors
    Transazioni
    • 28 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 14 dic 2006
    Consegnato il 22 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due of each obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Capita Trust Company Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 15 mag 2006
    Consegnato il 23 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 23 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 24 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any obligor to any beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 24 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 dic 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 nov 2002
    Consegnato il 15 nov 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and by such chargor to each beneficiary under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Credit Lyonnais
    Transazioni
    • 15 nov 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 apr 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SUN CP MIDCO LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    13 apr 2016Inizio della liquidazione
    29 mar 2017Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praticante
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praticante
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0