LEGACY COMPANY SIX LIMITED

LEGACY COMPANY SIX LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLEGACY COMPANY SIX LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04470423
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    • Attività di servizi di sistemi di sicurezza (80200) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DETECTOR TECHNOLOGIES LIMITED18 feb 200318 feb 2003
    HALLCO 789 LIMITED26 giu 200226 giu 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al15 apr 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Domanda di insolvenza

    Insolvency:sec state release of liq
    4 pagineLIQ MISC

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 set 2018

    11 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU a 4th Floor Abbey House Booth Street Manchester M2 4AB in data 16 nov 2018

    2 pagineAD01

    Rimozione del liquidatore per ordinanza del tribunale

    15 pagineLIQ10

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 20 set 2017

    10 pagineLIQ03

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Indirizzo della sede legale modificato da No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB England a 7th Floor Canal House 98 King Street Manchester M2 4WU in data 13 ott 2016

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 21 set 2016

    LRESSP

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name26 ago 2016

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 25 ago 2016

    RES15

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 15 apr 2017 al 30 giu 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio di micro-entità redatto al 15 apr 2016

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 26 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    2 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 giu 2016

    Stato del capitale al 14 giu 2016

    • Capitale: GBP 100,000
    SH01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 dic 2016 al 15 apr 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio di micro-entità redatto al 31 dic 2015

    2 pagineAA

    Nomina di Mr Michael James Newton come amministratore in data 09 giu 2016

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Pauline Anne Norstrom come amministratore in data 18 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael James Newton come amministratore in data 19 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nigel Fredrick Thomas Hugh Petrie come amministratore in data 17 apr 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Helen Pamela Doroszkiewicz come segretario in data 17 apr 2016

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1200 Daresbury Park Daresbury Warrington WA4 4HS a No. 1 Thellow Heath Park Northwich Road Antrobus Northwich Cheshire CW9 6JB in data 12 mar 2016

    1 pagineAD01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Nomina di Mr Michael James Newton come amministratore in data 13 gen 2016

    2 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di LEGACY COMPANY SIX LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    NEWTON, Michael James
    Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    Amministratore
    Abbey House
    Booth Street
    M2 4AB Manchester
    4th Floor
    EnglandBritishDirector24712770003
    BENTLEY-BUCHANAN, Sarah
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Strines Road
    Strines
    SK6 7GA Stockport
    180
    Cheshire
    United Kingdom
    British135492410001
    DOROSZKIEWICZ, Helen Pamela
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Segretario
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    161099500001
    MCCOMBE, David Walter
    The Woodlands
    Westcott Street
    RH4 3NU Westcott
    Surrey
    Segretario
    The Woodlands
    Westcott Street
    RH4 3NU Westcott
    Surrey
    BritishCompany Secretary80583660001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Segretario
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    British75778420001
    SHUTE, Richard Carl
    Apple Tree Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    Segretario
    Apple Tree Cottage
    Preston Road
    MK18 4HS Gawcott
    Buckinghamshire
    BritishGeneral Manager87650830001
    HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Segretario nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013280001
    AIRD, Robert Frederick
    Pentlands
    Hookley Lane, Elstead
    GU8 6JB Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Pentlands
    Hookley Lane, Elstead
    GU8 6JB Godalming
    Surrey
    BritishDirector61691910005
    FINN, Andrew Patrick
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    Amministratore
    Treetops
    241 Bramhall Moor Road
    SK7 5JL Hazel Grove Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishDirector169499300001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishManager75778420001
    MOORE, Ian Frederick
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    Amministratore
    8 Westland Drive
    PO7 5UG Waterlooville
    Hampshire
    EnglandBritishManager75778420001
    NEWTON, Michael James
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector24712770003
    NEWTON, Michael James
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    Frandley House
    Warrington Road Antrobus
    CW9 6HB Northwich
    Cheshire
    BritishDirector84319290001
    NORSTROM, Pauline Anne
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector148506110001
    PETRIE, Nigel Fredrick Thomas Hugh
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    Amministratore
    Northwich Road
    Antrobus
    CW9 6JB Northwich
    No. 1 Thellow Heath Park
    Cheshire
    England
    WalesBritishDirector51578980004
    WISEBERG, Adam Harris
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    Amministratore
    Tollbar Cottage Chester Road
    Over Tabley
    WA16 0PR Knutsford
    Cheshire
    EnglandBritishDirector141666340001
    HALLIWELLS DIRECTORS LIMITED
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    Amministratore delegato nominato
    St James's Court
    Brown Street
    M2 2JF Manchester
    Greater Manchester
    900013270001

    LEGACY COMPANY SIX LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 ott 2011
    Consegnato il 22 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 22 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 18 ott 2011
    Consegnato il 21 ott 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Michael James Newton
    Transazioni
    • 21 ott 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 04 mag 2006
    Consegnato il 10 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit of £5140.63 in an interest bearing deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Delta Developments (Alton) Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 25 giu 2003
    Consegnato il 02 lug 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    LEGACY COMPANY SIX LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    21 set 2016Inizio della liquidazione
    15 ago 2019Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Russell Stewart Cash
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    7th Floor, Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    David Thornhill
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester
    Praticante
    7th Floor Ship Canal House 98 King Street
    M2 4WU Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0