DORMCO HBI LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDORMCO HBI LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04482308
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DORMCO HBI LIMITED?

    • Agenti di commercio di una varietà di beni (46190) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova DORMCO HBI LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DORMCO HBI LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HAMLEYS BEAR INVESTMENT LIMITED27 ago 200227 ago 2002
    DWSCO 2308 LIMITED10 lug 200210 lug 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di DORMCO HBI LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al26 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per DORMCO HBI LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 19 dic 2012

    • Capitale: GBP 2,000,000
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Nomina di Mr Jean Marie Robert Le Francois Des Courtis come amministratore in data 17 set 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Rudolph Hidalgo come amministratore in data 17 set 2012

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Jean-Michel Victor Grunberg come amministratore in data 17 set 2012

    2 pagineAP01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 25 mar 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gudjon Karl Reynisson il 31 ago 2012

    2 pagineCH01

    Secondo deposito di AR01 precedentemente inviato alla Camera di Commercio aggiornato al 10 lug 2011

    16 pagineRP04

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 mag 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio redatto al 26 mar 2011

    8 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Note
    DataNota
    23 lug 2012Clarification A second filed AR01 was registered on the 23 July 2012

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 10 lug 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di DORMCO HBI LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    DUNN, Alasdair Andrew
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    Segretario
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    British109323280001
    DUNN, Alasdair Andrew
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    Amministratore
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    United KingdomBritish109323280002
    GRUNBERG, Jean-Michel Victor
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    Amministratore
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    FranceFrench171137000001
    HIDALGO, Rudolph
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    Amministratore
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    United KingdomFrench171137010001
    LE FRANCOIS DES COURTIS, Jean Marie Robert
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    Amministratore
    2 Fouberts Place
    London
    W1F 7PA
    FranceFrench173348100001
    REYNISSON, Gudjon Karl
    Carmel Way
    TW9 4EY London
    1
    Amministratore
    Carmel Way
    TW9 4EY London
    1
    United KingdomIcelander130510730002
    BURFORD, Christopher Victor
    19 Copperfields
    48 The Avenue
    BR3 5ER Beckenham
    Kent
    Segretario
    19 Copperfields
    48 The Avenue
    BR3 5ER Beckenham
    Kent
    British100078720001
    MATHER, Nicholas Charles Holt
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    Segretario
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    British135955360001
    PARKER, Ian Robert
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    Segretario
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    British70871000002
    DWS SECRETARIES LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Segretario nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023840001
    BURKE, Simon Paul
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    Amministratore
    35 Chepstow Place
    W2 4TT London
    United KingdomIrish30017870003
    MATHER, Nicholas Charles Holt
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    Amministratore
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    United KingdomBritish135955360001
    OSBORNE, Katherine Anne
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    Amministratore
    Glebe Farm
    Old Weston Road
    PE28 5AG Brington
    Cambs
    British72141580002
    PARKER, Ian Robert
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    Amministratore
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    British70871000002
    WATKINSON, John Dudley
    Fir Tree Cottage
    36 West Perry
    PE18 0BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Fir Tree Cottage
    36 West Perry
    PE18 0BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    British66949520001
    DWS DIRECTORS LIMITED
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    Amministratore delegato nominato
    Five Chancery Lane
    Cliffords Inn
    EC4A 1BU London
    900023830001

    DORMCO HBI LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 giu 2011
    Consegnato il 15 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 08 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land under t/ns HD425461, NGL390956 and NGL614726. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Supplemental debenture
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 15 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) on Behalf of Itself and the Banks Andfinancial Institutions from Time to Time Parties to the Secured Documents.
    Transazioni
    • 15 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A target group debenture supplemental to a composite guararantee and debenture dated 13 august 2003
    Creato il 02 set 2003
    Consegnato il 09 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Holder)
    Transazioni
    • 09 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 13 ago 2003
    Consegnato il 28 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 05 set 2002
    Consegnato il 20 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 20 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2003Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0