XERCERS 2014 LIMITED

XERCERS 2014 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàXERCERS 2014 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04484545
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di XERCERS 2014 LIMITED?

    • (2852) /

    Dove si trova XERCERS 2014 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    BWC BUSINESS SOLUTIONS LIMITED
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di XERCERS 2014 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    04484545 LIMITED25 lug 201425 lug 2014
    D. L. I. PRECISION ENGINEERING LIMITED10 set 200210 set 2002
    EVER 1831 LIMITED12 lug 200212 lug 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di XERCERS 2014 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2006

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per XERCERS 2014 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per XERCERS 2014 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 08 giu 2015

    1 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 08 giu 2015

    19 pagine2.24B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 03 mar 2015

    20 pagine2.24B

    Risultato della riunione dei creditori

    4 pagine2.23B

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    4 pagineMR04

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    35 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 2 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed 04484545 LIMITED\certificate issued on 14/08/14
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name14 ago 2014

    Avviso di cambio di nome"

    CONNOT

    Nomina di Mr David Shannon come amministratore in data 31 lug 2014

    3 pagineAP01

    Ripristino per ordine del tribunale

    7 pagineAC92

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed D. L. I. Precision engineering\certificate issued on 25/07/14
    CERTNM

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione

    13 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 19 nov 2008

    10 pagine2.24B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    7 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    32 pagine2.17B

    Chi sono gli amministratori di XERCERS 2014 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OLIVER, Jennifer
    Broom House Cocken Lane
    Leamside
    DH4 6QN Houghton Le Spring
    County Durham
    Segretario
    Broom House Cocken Lane
    Leamside
    DH4 6QN Houghton Le Spring
    County Durham
    British59740360001
    OLIVER, William Harvey Dickinson
    Broom House Cocken Lane
    Leamside
    DH4 6QN Houghton Le Spring
    Durham
    Amministratore
    Broom House Cocken Lane
    Leamside
    DH4 6QN Houghton Le Spring
    Durham
    EnglandEnglish26775110001
    SHANNON, David
    Park Place
    LS1 2RU Leeds
    8
    Amministratore
    Park Place
    LS1 2RU Leeds
    8
    EnglandBritish171620830001
    WELLS, Barry Michael
    2 Woodlands Walk
    Mannings Heath
    RH13 6JG Horsham
    West Sussex
    Amministratore
    2 Woodlands Walk
    Mannings Heath
    RH13 6JG Horsham
    West Sussex
    EnglandBritish64180770001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Amministratore delegato nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    XERCERS 2014 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 29 giu 2006
    Consegnato il 18 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 18 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental chattel mortgage
    Creato il 05 mag 2006
    Consegnato il 09 mag 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Nakamura tome tmc 15H cnc lathe (1990) s/n 04503 8 station turret fanuc 10T control, daewoo puma 200 msc cnc turning centre, s/p PM200167 (YOM1998), eurospark espark ES750 electro discharge machine (yom 1997) c/w system 3R and the benefit of all insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 09 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Supplemental chattel mortgage
    Creato il 30 giu 2004
    Consegnato il 02 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The goods being hitachi seiki hitec-turn 20R turning centre (yom 1995) seicos l multi cnc control 10 station turret tool setter 3 jaw chuck coolant equipmjnt s/no NRR20299, colchester student 1800 gap bed centre lathe 25 bc (1980) c/w 3 jaw chuck taper turning qctp & holders coolant s/no 4/0008/07326DD, colchetsre mascot 1600 gap bed centre lathe 80 bc (1979)c/w 3 & 4 jaw chucks qctp & holders face plate steady s/no 7/0205/13991 for further details of the goods charged please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • State Securities PLC
    Transazioni
    • 02 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Book debts debenture
    Creato il 27 giu 2004
    Consegnato il 06 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    First fixed charge on all book debts and other debts. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Fixed and qualifying floating charge
    Creato il 27 giu 2004
    Consegnato il 06 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Five Arrows Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 06 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage deed
    Creato il 28 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £175,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land lying on the north west side of front street trimdon grange county durham title absolute t/n DU166509.
    Persone aventi diritto
    • Kent Reliance Building Society
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 nov 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 09 set 2002
    Consegnato il 18 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly k/a ever 1831 limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 18 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 14 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 18 set 2002
    In corso
    Importo garantito
    £200,000.00 and all other monies due or to become due from the company (formerly known as ever 1831 limited) to the chargee
    Brevi particolari
    Property k/a trimdon industrial estate, trimdon grange, county durham t/no. DU166509.
    Persone aventi diritto
    • Trygve Lonnebotn
    Transazioni
    • 18 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge deed
    Creato il 06 set 2002
    Consegnato il 18 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as ever 1831 limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that freehold land on the north west side of front street trimdon grange durham t/no DU166509 the goodwill, benefit of any shareholdings, present and future licences, consents, permissions and agreements, all warranties, guarantees and indemnities, contracts and agreements, contracts of insurance. By way of floating charge over all other property assets rights and equipment and all its undertakings.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 18 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 02 set 2002
    Consegnato il 03 set 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed charge over all book and other debts present and future and the benefit of all contracts and policies of insurance and by way of floating charge the undertaking and all property assets and rights of the company present and future.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 03 set 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 21 ago 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    XERCERS 2014 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 mag 2008Inizio dell'amministrazione
    18 mag 2009Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Paul Andrew Whitwam
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Praticante
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    David Leighton Cockshott
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Praticante
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    2
    DataTipo
    04 set 2014Inizio dell'amministrazione
    08 giu 2015Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gary E Blackburn
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Praticante
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Paul Andrew Whitwam
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds
    Praticante
    Bwc Business Solutions
    8 Park Place
    LS1 2RU Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0