DRAKES GROUP LIMITED

DRAKES GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDRAKES GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04486816
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DRAKES GROUP LIMITED?

    • Attività giudiziarie e di giustizia (84230) / Amministrazione pubblica e difesa; previdenza sociale obbligatoria
    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova DRAKES GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Rutland House 8th Floor
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DRAKES GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BRIDGMAN COMMUNICATIONS LIMITED27 ago 200227 ago 2002
    BDBCO NO.582 LIMITED16 lug 200216 lug 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di DRAKES GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mag 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per DRAKES GROUP LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per DRAKES GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    1 pagineMR04

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 29 mag 2015

    • Capitale: GBP 101
    4 pagineSH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2014

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 lug 2014

    Stato del capitale al 21 lug 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Squire Sanders Secretarial Services Limited il 02 giu 2014

    1 pagineCH04

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2013

    7 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Hughes il 13 dic 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Leslie Crichton il 11 dic 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Squire Sanders Secretarial Services Limited come segretario

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Oakwood Corporate Secretary Limited come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Webber House 26-28 Market Street Altrincham Cheshire WA14 1PF United Kingdom* in data 15 nov 2013

    1 pagineAD01

    Dettagli del segretario cambiati per Oakwood Corporate Secretary Limited il 13 ago 2013

    2 pagineCH04

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital22 lug 2013

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 22 lug 2013

    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mag 2012

    7 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr John Leslie Crichton il 14 gen 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Gareth Hughes il 14 gen 2013

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 16 lug 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 mar 2012 al 31 mag 2012

    1 pagineAA01

    legacy

    3 pagineMG02

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di DRAKES GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SQUIRE PATTON BOGGS SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu)
    United Kingdom
    Segretario
    Rutland House
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Squire Sanders (Uk) Llp (Ref: Csu)
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione2911328
    73037780028
    CRICHTON, John Leslie
    8th Floor
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    United Kingdom
    Amministratore
    8th Floor
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    United Kingdom
    United KingdomBritish169193380002
    HUGHES, Gareth
    8th Floor
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    United Kingdom
    Amministratore
    8th Floor
    148 Edmund Street
    B3 2JR Birmingham
    Rutland House
    United Kingdom
    EnglandBritish169206750002
    HUGHES, Gareth
    Top Flat 18 Lambourne Road
    Clapham
    SW4 0LY London
    Segretario
    Top Flat 18 Lambourne Road
    Clapham
    SW4 0LY London
    British83038100001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BROADWAY SECRETARIES LIMITED
    50 Broadway
    Westminster
    SW1H 0BL London
    Segretario
    50 Broadway
    Westminster
    SW1H 0BL London
    128151310001
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Segretario
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione7038430
    146358090001
    CHRISTIE, Archie Jack
    Bridgman House
    37 Sun Street
    EN9 1EL Waltham Abbey
    Essex
    Amministratore
    Bridgman House
    37 Sun Street
    EN9 1EL Waltham Abbey
    Essex
    British82478520002
    MILLERICK, Francis John
    Bridgman House
    37 Sun Street
    EN9 1EL Waltham Abbey
    Essex
    Amministratore
    Bridgman House
    37 Sun Street
    EN9 1EL Waltham Abbey
    Essex
    EnglandBritish78425170006
    SIMCOX, Daren Andrew
    Bridgman House
    37 Sun Street
    EN9 1EL Waltham Abbey
    Essex
    Amministratore
    Bridgman House
    37 Sun Street
    EN9 1EL Waltham Abbey
    Essex
    United KingdomBritish78425160006
    BROADWAY DIRECTORS LIMITED
    50 Broadway
    Westminster
    SW1H 0BL London
    Amministratore
    50 Broadway
    Westminster
    SW1H 0BL London
    80383050001

    DRAKES GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 04 apr 2008
    Consegnato il 10 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as bridgeman communications limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 10 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Omnibus guarantee and set off agreement
    Creato il 18 nov 2003
    Consegnato il 01 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or drakes group limited or the bridgman group limited or any of them on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name of the company whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 18 nov 2003
    Consegnato il 01 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 01 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 mag 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental deed of composite guarantee and debenture dated 31 may 2002
    Creato il 12 feb 2003
    Consegnato il 03 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and the discharge of all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for itself and the other beneficiaries) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gresham Trust PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 lug 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 feb 2003
    Consegnato il 03 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies and the discharge of all obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee (as security trustee for itself and the other beneficiaries) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sidney Bruce Duncan Simcox
    Transazioni
    • 03 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0