Q-PARK (GLASGOW) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | Q-PARK (GLASGOW) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04500926 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Mazars Llp 45 Church Street B3 2RT Birmingham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| DUNWILCO (953) LIMITED | 01 ago 2002 | 01 ago 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2016 |
Quali sono le ultime deposizioni per Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione | 1 pagine | GAZ2 | ||||||||||
Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri | 14 pagine | LIQ13 | ||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a 72 Merrion Street Leeds LS2 8LW | 2 pagine | AD02 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 72 Merrion Street Leeds Yorkshire LS2 8LW a Mazars Llp 45 Church Street Birmingham B3 2RT in data 19 ott 2018 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di un liquidatore volontario | 3 pagine | 600 | ||||||||||
Dichiarazione di solvibilità | 5 pagine | LIQ01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 2 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 045009260006 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2016 | 19 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 045009260005 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 mar 2017 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mar 2016 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 15 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 3 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 045009260006, creata il 11 ago 2015 | 9 pagine | MR01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 045009260005, creata il 29 lug 2015 | 41 pagine | MR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mar 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Dimissioni del revisore | 1 pagine | AUD | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 19 mar 2014 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessazione della carica di Richard Mark Powell come segretario in data 15 nov 2013 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLIS, Stephen Mark | Segretario | 4 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | British | 53625240002 | ||||||
| BIDDER, Adam John | Amministratore | Kensington Court Lodge Moor S10 4NL Sheffield 4 South Yorkshire | England | British | 100999070001 | |||||
| ELLIS, Stephen Mark | Amministratore | 4 Hilton Mews Bramhope LS16 9LF Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | 53625240002 | |||||
| ASHBEE, Alan Brian | Segretario | Stone Acre Harewood Road LS22 5BZ Collingham West Yorkshire | British | 10710300005 | ||||||
| BIDDER, Adam John | Segretario | Kensington Court Lodge Moor S10 4NL Sheffield 4 South Yorkshire | British | 100999070001 | ||||||
| POWELL, Richard Mark | Segretario | 23 Wedderburn Road HG2 7QH Harrogate North Yorkshire | British | 117250990001 | ||||||
| PRIOR, Karen Lesley | Segretario | 16 Silcoates Avenue Wrenthorpe WF2 0UP Wakefield West Yorkshire | British | 45509020001 | ||||||
| TAYLOR, Richard Ian | Segretario | Merrion Street LS2 8LW Leeds 72 Yorkshire | British | 134130960001 | ||||||
| D.W. COMPANY SERVICES LIMITED | Segretario | 4th Floor, Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 613080003 | |||||||
| ASHBEE, Alan Brian | Amministratore | Stone Acre Harewood Road LS22 5BZ Collingham West Yorkshire | United Kingdom | British | 10710300005 | |||||
| MILNOR, Lisa Rachael | Amministratore | Goal Farm Hellifield BD23 4JR Skipton North Yorkshire | United Kingdom | British | 53306760001 | |||||
| PRIOR, Karen Lesley | Amministratore | 16 Silcoates Avenue Wrenthorpe WF2 0UP Wakefield West Yorkshire | United Kingdom | British | 45509020001 | |||||
| SYERS, Duncan Sinclair | Amministratore | Paddocks Harewood Road Collingham LS22 5BY Wetherby West Yorkshire | England | British | 95929170001 | |||||
| TAYLOR, Richard Ian | Amministratore | Merrion Street LS2 8LW Leeds 72 Yorkshire | British | 134130960001 | ||||||
| THUIS, Theo | Amministratore | D'Artagnanlaan 44 Maastricht 6213 Ck The Netherlands | Netherlands | Dutch | 94285200001 | |||||
| D W DIRECTOR 2 LIMITED | Amministratore | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh | 73984150001 | |||||||
| D.W. DIRECTOR 1 LIMITED | Amministratore | 4th Floor Saltire Court 20 Castle Terrace EH1 2EN Edinburgh Lothian | 83454900001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di Q-PARK (GLASGOW) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q-Park Developments Ltd | 06 apr 2016 | Merrion Street LS2 8LW Leeds 72 West Yorkshire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Q-PARK (GLASGOW) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 11 ago 2015 Consegnato il 14 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione All and whole the interest in t/no GLA179031. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A registered charge | Creato il 29 lug 2015 Consegnato il 07 ago 2015 | Soddisfatta integralmente | ||
Breve descrizione L/H st. Enich car park, 114-118 howard street, glasgow t/no GLA179031. Contiene un'ipotesi negativa: Sì Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security executed on 18 november 2011 | Creato il 02 dic 2011 Consegnato il 20 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the secured creditors or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and whole the interest in the lease between the most reverend mario conti kc *H.s, ph.l, S.T.l, D.d F.R.S.e, roman catholic archbishop of glasgow and others as trustees of the roman catholic archdiocese of glasgow and the chargor dated 24TH december 2003 and 4TH july 2004 t/no GLA179031. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| English security agreement | Creato il 18 nov 2011 Consegnato il 01 dic 2011 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due to the secured creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Floating charge over all assets, by way of legal mortgage any real property including all buildings, fixtures, fixed plant and machinery, investments, assigns all rights under any hedging arrangements. See image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Standard security | Creato il 27 nov 2009 Consegnato il 16 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All and the whole the interest in the lease see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security agreement | Creato il 27 nov 2009 Consegnato il 11 dic 2009 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over any additional property and assets present and future and all shares, any dividend or interest, including credit balances, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Q-PARK (GLASGOW) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Liquidazione volontaria dei soci |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0