SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED

SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04502016
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    • Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale

    Dove si trova SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HIGHFIELD HEALTHCARE CENTRES LIMITED23 ott 200223 ott 2002
    SOUTHWEST LIMITED02 ago 200202 ago 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012

    1 pagineTM02

    Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione

    6 pagine1.4

    Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital14 ago 2012

    Stato del capitale al 14 ago 2012

    • Capitale: GBP 600,002
    SH01

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    4 pagine1.1

    Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    28 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Cessazione della carica di William Mcleish come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 02 ago 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Explanatory statment to sole member 14/05/2010
    RES13

    Bilancio redatto al 27 set 2009

    25 pagineAA

    Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010

    2 pagineCH01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di David Smith come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Stephen Jonathan
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish163496070001
    JOYCE, Meriel Lucy Ann
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    Segretario
    21 Easter Steil
    EH10 5XE Edinburgh
    British16385330010
    KAUL, Sheila
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    Segretario
    35 Princes Court
    HA9 7JJ Wembley
    Middlesex
    British70194600001
    MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    158305970001
    MCLEISH, William David
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Segretario
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    British168970640001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Segretario nominato
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    ASARIA, Mohamed Saleem
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    Amministratore
    Fringewood Close
    HA6 2TB Northwood
    8
    Middlesex
    EnglandBritish13927880001
    BOLOT, Timothy James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish107837080002
    BUCHAN, William James
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish79917240001
    COLVIN, William
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    Senang
    Pyrford Woods Road
    GU22 8QR West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890003
    COLVIN, William
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    Amministratore
    1 Patterdale
    Coldharbour Road
    KT14 6JN West Byfleet
    Surrey
    United KingdomBritish51697890001
    FARMER, Nicholas John
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish124228290001
    FINNIS, Pam
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish133719530001
    FOULKES, Kamma
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish111188390002
    GROOMBRIDGE, Kevin John
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    Amministratore
    51 Old Croft Road
    ST17 0NL Stafford
    EnglandBritish105722880001
    JOYCE, Martin Patrick
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    Amministratore
    La Rue A
    St Peter Port
    GY1 1QG Guernsey
    United KingdomBritish27130160009
    LOCK, Jason David
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    Amministratore
    32 Monkton Rise
    TS14 6BG Guisborough
    Chessington House
    EnglandBritish144822040001
    MALHAM, Janette
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    Amministratore
    The Limekilns
    9a Elm Grove
    TS26 8LZ Hartlepool
    EnglandBritish91088900003
    MCKEEVER, Pauline Ann
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    Amministratore
    40 Pine Place
    G5 0BX Glasgow
    BritainBritish91521130001
    MCQUAID, Michael James
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Baily Bach
    Cobham Way
    KT24 5BH East Horsley
    Surrey
    United KingdomBritish89052830001
    MIDMER, Richard Neil
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    EnglandBritish110640170001
    MURPHY, John
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    Amministratore
    4 Lochend Road
    KA10 6JJ Troon
    United KingdomBritish26177180004
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Amministratore
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    MURRAY, Andrew John
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    Amministratore
    10 Rosgill Drive
    Middleton
    M24 4SQ Manchester
    Lancashire
    British110957990001
    POYNTON, Ellen
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    Amministratore
    Whiteoaks
    10 St Richards Close, Wychbold
    WR9 7PP Droitwich
    United KingdomBritish89071020004
    RUTTER, Christopher
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    Amministratore
    15 The Dell
    DL14 7HJ Bishop Auckland
    County Durham
    British103588940001
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Amministratore
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Amministratore
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    Amministratore
    Southgate House, Archer Street
    Darlington
    DL3 6AH County Durham
    United KingdomBritish147997950001
    SMITH, David Andrew, Mr.
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    Amministratore
    Durham Road
    Low Fell
    NE9 5AL Gateshead
    377
    England
    England
    United KingdomBritish147997950001
    STEIN, Anthony Karl
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    Amministratore
    9 Birmingham Road
    Coughton
    B49 5HR Alcester
    United KingdomBritish109518530001
    WILSON, Mark Stephen
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    Amministratore
    9 Wheatear Lane
    Ingleby Barwick
    TS17 0TB Stockton On Tees
    British90893350001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Amministratore delegato nominato
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 07 mag 2003
    Consegnato il 15 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit; the interest; the deposit account and the deposit balance.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transazioni
    • 15 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 07 mag 2003
    Consegnato il 10 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Leasehold premises situate at the limes nursing home main street whaley thorns nether langwith mansfield nottinghamshire NG20 9HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transazioni
    • 10 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 mag 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 apr 2003
    Consegnato il 09 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit the interest the deposit account and the deposit balance.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transazioni
    • 09 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Rent deposit deed
    Creato il 29 apr 2003
    Consegnato il 08 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit, all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "regis house nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum of £10,080. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 10 Limited
    Transazioni
    • 08 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 apr 2003
    Consegnato il 02 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises at beech tree house 120-122 himley road dudley west midlands DY1 2QQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Mortgage debenture
    Creato il 29 apr 2003
    Consegnato il 02 mag 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises at regis house nursing home 29 causeway blackheath rowley regis warley west midlands B65 8AA. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.10 Limited
    Transazioni
    • 02 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Rent deposit deed
    Creato il 24 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit being the sum of £39,348 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "woodcross mental care centre deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 24 mar 2003
    Consegnato il 27 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H premises situate at woodcross mental care centre 23 reeves street bloxwich walsall west midlands WS3 2DG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transazioni
    • 27 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 apr 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Rent deposit deed
    Creato il 20 mar 2003
    Consegnato il 03 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 3 Limited
    Transazioni
    • 03 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 20 mar 2003
    Consegnato il 25 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.3 Limited
    Transazioni
    • 25 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 28 gen 2003
    Consegnato il 05 feb 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The l/h property k/a woodcross house nursing home (sedgley) woodcross street, woodcross, wolverhampton, WV14 9RT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No. 5 Limited
    Transazioni
    • 05 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 mag 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 10 mag 2004Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    Rent deposit deed
    Creato il 28 gen 2003
    Consegnato il 01 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Nhp Securities No.5 Limited
    Transazioni
    • 01 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    20 giu 2012Data della riunione per approvare il CVA
    20 ago 2012Data di completamento o cessazione del CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Howard Smith
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds
    Praticante
    1 The Embankment
    Neville Street
    LS1 4DW Leeds

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0