SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04502016 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | Sì |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
- Altre attività di assistenza sanitaria (86900) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| HIGHFIELD HEALTHCARE CENTRES LIMITED | 23 ott 2002 | 23 ott 2002 |
| SOUTHWEST LIMITED | 02 ago 2002 | 02 ago 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 30 set 2010 |
Quali sono le ultime deposizioni per SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario in data 09 ott 2012 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Notifica di esecuzione dell'accordo di composizione | 6 pagine | 1.4 | ||||||||||
Cessazione della carica di Timothy James Bolot come amministratore in data 17 ago 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore | 4 pagine | 1.1 | ||||||||||
Cessazione della carica di William James Buchan come amministratore in data 15 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Andrew Smith come amministratore in data 01 nov 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Stephen Jonathan Taylor come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Timothy James Bolot come amministratore in data 26 ott 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 set 2010 | 28 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 3 pagine | AR01 | ||||||||||
Cessazione della carica di William Mcleish come segretario | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Nomina di Francis Declan Finbar Tempany Mccormack come segretario | 1 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Richard Midmer come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 02 ago 2010 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 3 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 27 set 2009 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Andrew Smith il 07 gen 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di David Smith come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr David Andrew Smith come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Kamma Foulkes come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TAYLOR, Stephen Jonathan | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 163496070001 | |||||
| JOYCE, Meriel Lucy Ann | Segretario | 21 Easter Steil EH10 5XE Edinburgh | British | 16385330010 | ||||||
| KAUL, Sheila | Segretario | 35 Princes Court HA9 7JJ Wembley Middlesex | British | 70194600001 | ||||||
| MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158305970001 | |||||||
| MCLEISH, William David | Segretario | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
| BRIAN REID LTD. | Segretario nominato | 5 Logie Mill Beaverbank Office Park Logie Green Road EH7 4HH Edinburgh | 900018660001 | |||||||
| ASARIA, Mohamed Saleem | Amministratore | Fringewood Close HA6 2TB Northwood 8 Middlesex | England | British | 13927880001 | |||||
| BOLOT, Timothy James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 107837080002 | |||||
| BUCHAN, William James | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 79917240001 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890003 | |||||
| COLVIN, William | Amministratore | 1 Patterdale Coldharbour Road KT14 6JN West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | 51697890001 | |||||
| FARMER, Nicholas John | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 124228290001 | |||||
| FINNIS, Pam | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 133719530001 | |||||
| FOULKES, Kamma | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 111188390002 | |||||
| GROOMBRIDGE, Kevin John | Amministratore | 51 Old Croft Road ST17 0NL Stafford | England | British | 105722880001 | |||||
| JOYCE, Martin Patrick | Amministratore | La Rue A St Peter Port GY1 1QG Guernsey | United Kingdom | British | 27130160009 | |||||
| LOCK, Jason David | Amministratore | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | 144822040001 | |||||
| MALHAM, Janette | Amministratore | The Limekilns 9a Elm Grove TS26 8LZ Hartlepool | England | British | 91088900003 | |||||
| MCKEEVER, Pauline Ann | Amministratore | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | 91521130001 | |||||
| MCQUAID, Michael James | Amministratore | Baily Bach Cobham Way KT24 5BH East Horsley Surrey | United Kingdom | British | 89052830001 | |||||
| MIDMER, Richard Neil | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | 110640170001 | |||||
| MURPHY, John | Amministratore | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | 26177180004 | |||||
| MURPHY, John | Amministratore | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
| MURRAY, Andrew John | Amministratore | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| MURRAY, Andrew John | Amministratore | 10 Rosgill Drive Middleton M24 4SQ Manchester Lancashire | British | 110957990001 | ||||||
| POYNTON, Ellen | Amministratore | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | 89071020004 | |||||
| RUTTER, Christopher | Amministratore | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | 103588940001 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Amministratore | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Amministratore | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| SMITH, David Andrew, Mr. | Amministratore | Durham Road Low Fell NE9 5AL Gateshead 377 England England | United Kingdom | British | 147997950001 | |||||
| STEIN, Anthony Karl | Amministratore | 9 Birmingham Road Coughton B49 5HR Alcester | United Kingdom | British | 109518530001 | |||||
| WILSON, Mark Stephen | Amministratore | 9 Wheatear Lane Ingleby Barwick TS17 0TB Stockton On Tees | British | 90893350001 | ||||||
| STEPHEN MABBOTT LTD. | Amministratore delegato nominato | 14 Mitchell Lane G1 3NU Glasgow | 900018650001 |
SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Rent deposit deed | Creato il 07 mag 2003 Consegnato il 15 mag 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit; the interest; the deposit account and the deposit balance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 07 mag 2003 Consegnato il 10 mag 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Leasehold premises situate at the limes nursing home main street whaley thorns nether langwith mansfield nottinghamshire NG20 9HU. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 29 apr 2003 Consegnato il 09 mag 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit the interest the deposit account and the deposit balance. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 29 apr 2003 Consegnato il 08 mag 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit, all interest, the deposit account being an interest bearing account specifically designated "regis house nursing home deposit account" and the deposit balance being the sum of £10,080. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 29 apr 2003 Consegnato il 02 mag 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises at beech tree house 120-122 himley road dudley west midlands DY1 2QQ. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 29 apr 2003 Consegnato il 02 mag 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises at regis house nursing home 29 causeway blackheath rowley regis warley west midlands B65 8AA. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 24 mar 2003 Consegnato il 03 apr 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit being the sum of £39,348 all interest the deposit account being an interest bearing account specifically designated "woodcross mental care centre deposit account" and the deposit balance being the sum from time to time standing to the credit of the deposit account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 24 mar 2003 Consegnato il 27 mar 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari L/H premises situate at woodcross mental care centre 23 reeves street bloxwich walsall west midlands WS3 2DG. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 20 mar 2003 Consegnato il 03 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 20 mar 2003 Consegnato il 25 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Mortgage debenture | Creato il 28 gen 2003 Consegnato il 05 feb 2003 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari The l/h property k/a woodcross house nursing home (sedgley) woodcross street, woodcross, wolverhampton, WV14 9RT. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Rent deposit deed | Creato il 28 gen 2003 Consegnato il 01 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Brevi particolari The deposit, all interest, the deposit account and the deposit balance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
SOUTHERN CROSS HEALTHCARE CENTRES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?
| Numero di pratica | Date | Tipo | Professionisti | Altro | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA) |
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0