BSPOKE UNDERWRITING LTD
Panoramica
| Nome della società | BSPOKE UNDERWRITING LTD |
|---|---|
| Stato della società | Attiva |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04506493 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | No |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di BSPOKE UNDERWRITING LTD?
- Attività di agenti e broker di assicurazione (66220) / Attività finanziarie e assicurative
Dove si trova BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Indirizzo della sede legale | Brookfield Court Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| UK GENERAL INSURANCE LIMITED | 11 apr 2011 | 11 apr 2011 |
| UK UNDERWRITING LIMITED | 03 ott 2002 | 03 ott 2002 |
| HALLCO 806 LIMITED | 08 ago 2002 | 08 ago 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Scaduto | No |
|---|---|
| Prossimi bilanci | |
| Fine del prossimo esercizio al | 31 dic 2025 |
| Scadenza dei prossimi bilanci il | 30 set 2026 |
| Ultimi bilanci | |
| Ultimi bilanci redatti al | 30 mar 2025 |
Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Ultima dichiarazione di conferma redatta al | 08 ago 2026 |
|---|---|
| Scadenza della prossima dichiarazione di conferma | 22 ago 2026 |
| Ultima dichiarazione di conferma | |
| Prossima dichiarazione di conferma redatta al | 08 ago 2025 |
| Scaduto | No |
Quali sono le ultime deposizioni per BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 mar 2026 al 31 dic 2025 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2025 | 31 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Craig Richard Hunter come amministratore in data 01 feb 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Robert Purvis come amministratore in data 01 mar 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Mr Ryan Mark Gill come amministratore in data 01 feb 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Joanne Elizabeth Deveney come amministratore in data 01 feb 2026 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mr Robert Alexander Paul Witts come amministratore in data 22 gen 2026 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 045064930013 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 045064930014 in pieno | 1 pagine | MR04 | ||||||||||
Cessazione della carica di James Robert Purvis come amministratore in data 06 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanne Elizabeth Deveney come amministratore in data 14 ago 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Craig Richard Hunter come amministratore in data 06 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Ryan Mark Gill come amministratore in data 06 ago 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2025 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 045064930014, creata il 05 ago 2025 | 39 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Miss Clare Louise Knight come amministratore in data 13 giu 2025 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jeffrey Turner come amministratore in data 28 gen 2025 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2024 | 31 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2024 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Mr James Robert Purvis come amministratore in data 20 mar 2024 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 30 mar 2023 | 32 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mr Jeffrey Turner come amministratore in data 08 dic 2023 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 08 ago 2023 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Certificato di cambio di nome Company name changed uk general insurance LIMITED\certificate issued on 13/04/23 | 2 pagine | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Cambio di nome" con richiesta di commenti dall'organismo competente | 2 pagine | NM06 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLERTON, Penelope Jane | Segretario | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | 296527590001 | |||||||
| GILL, Ryan Mark | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 184068890001 | |||||
| HUNTER, Craig Richard | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | United Kingdom | British | 206294080001 | |||||
| KNIGHT, Clare Louise | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | United Kingdom | British | 337138930001 | |||||
| PURVIS, James Robert | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 113566500003 | |||||
| SMYTH, Timothy John | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 271006310001 | |||||
| WITTS, Robert Alexander Paul | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 277300400001 | |||||
| BLOTT, Stephen | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 202286270001 | |||||||
| BLOTT, Stephen | Segretario | Low Wood Wilsden BD15 0JS Bradford 30 West Yorkshire England | British | 139352410001 | ||||||
| BROPHY, Elizabeth Anne | Segretario | Selby Road Swillington Common LS15 4LG Leeds 3.1 Carrwood Park West Yorkshire England | 272366560001 | |||||||
| FULLERTON, Penelope Jane | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | 184071050001 | |||||||
| FULLERTON, Penny | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 206864670001 | |||||||
| HOPKINS, Trevor Charles William | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | 250187900001 | |||||||
| KEILL, Tracy Elizabeth | Segretario | 'Verandah House' 8 Pokiok Road Smith's Fl05 Bermuda | British | 127332980001 | ||||||
| MCMAHON, Andrew Neil Mcintyre | Segretario | 39 Lynwood Grove BR6 0BD Orpington Kent | British | 75598460002 | ||||||
| ORTON, Jeffrey Christopher | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | 185572800001 | |||||||
| ZACZKIEWICZ, Stacey | Segretario | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | 170326090001 | |||||||
| EVERSECRETARY LIMITED | Segretario | Eversheds House 70 Great Bridgewater Street M1 5ES Manchester | 60471940015 | |||||||
| HALLIWELLS SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | St James's Court Brown Street M2 2JF Manchester Greater Manchester | 900013280001 | |||||||
| BARCLAY, Ian James | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | England | British | 184779440002 | |||||
| BEALES, Karen Anne | Amministratore | Gibraltar Island Road Old Mill Business Park LS10 1RJ Leeds Cast House England | England | British | 135540180002 | |||||
| BEAN, Jane Ann | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 158293780001 | |||||
| BLACKHAM, Christopher Layton | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 140582420001 | |||||
| BRADBURY, Susan Patricia | Amministratore | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 40471660002 | |||||
| BRADBURY, Susan Patricia | Amministratore | Causeway Foot Rochdale Road Pole Moor Outlane HD3 3FQ Huddersfield West Yorkshire | United Kingdom | British | 40471660002 | |||||
| BRUCE, Catherine | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | England | British | 113821420001 | |||||
| CARTER, Patrick Robert, Lord | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 172561150001 | |||||
| CARTER, Patrick Robert, Lord | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire England | United Kingdom | British | 172561150001 | |||||
| COX, Jonathan James, Mr. | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | England | British | 219625400001 | |||||
| DEVENEY, Joanne Elizabeth | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | Wales | British | 134674120002 | |||||
| GILL, Ryan Mark | Amministratore | Selby Road Garforth LS25 1NB Leeds Brookfield Court England | England | British | 184068890001 | |||||
| GREENWOOD, Jonathan Paul | Amministratore | 3 The Poplars Village Street Norwood Green HX3 8QQ Halifax West Yorkshire | British | 110139460001 | ||||||
| HANFORD, Timothy John | Amministratore | Old Mill Business Park Gibraltar Island Road LS10 1RJ Leeds Cast House West Yorkshire | United Kingdom | British | 229928240001 | |||||
| HARNBY, Alastair John | Amministratore | Dene Bank BD16 4AR Bingley 21 West Yorkshire Uk | United Kingdom | British | 172070220002 | |||||
| HODES, Jonathan | Amministratore | 81 Lauderdale Mansions Lauderdale Road W9 1LX London | British | 79523100001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di BSPOKE UNDERWRITING LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Holdco Limited | 06 apr 2016 | Selby Road Swillington Common LS15 4LG Leeds Building 3.1, Carrwood Park England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0