2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED
Panoramica
| Nome della società | 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04507423 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Cannon Place 78 Cannon Street EC4N 6AF London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| JARVISHELF 33 LIMITED | 09 ago 2002 | 09 ago 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2020 |
Quali sono le ultime deposizioni per 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Stato del capitale al 24 dic 2021
| 5 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 1 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Mrs Sally-Ann Brooks come amministratore in data 15 dic 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020 | 16 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2019 | 22 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 12 ago 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2018 | 23 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di David Geoffrey Lewis come amministratore in data 01 feb 2019 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2017 | 24 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2016 | 26 pagine | AA | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 2 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 1 in pieno | 4 pagine | MR04 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr David Geoffrey Lewis il 12 feb 2016 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ago 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 mar 2015 | 18 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 ago 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Chi sono gli amministratori di 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRASTRUCTURE MANAGERS LIMITED | Segretario | Floor 11 Thistle Street EH2 1DF Edinburgh 2nd United Kingdom |
| 128530180002 | ||||||||||
| BROOKS, Sally-Ann | Amministratore | 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 197780410001 | |||||||||
| GEORGE, John Philip | Amministratore | 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff Third Floor United Kingdom | Wales | British | 72272750003 | |||||||||
| BOWLER, David William | Segretario | Watling Lane OX10 7JG Dorcester On Thames 14 Oxon | British | 34940010004 | ||||||||||
| SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Segretario | Meridian House The Crescent YO24 1AW York North Yorkshire | 70053320013 | |||||||||||
| BIRCH, Alan Edward | Amministratore | 7 Silsbury Grove Standish WN6 0EY Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 90700330001 | |||||||||
| BRINDLEY, Nigel Anthony John | Amministratore | 5th Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX | United Kingdom | British | 88757730001 | |||||||||
| GARDINER, Patrick Hugh | Amministratore | Greystones Cornsland CM14 4JL Brentwood Essex | British | 63883470001 | ||||||||||
| GORDON, Ray | Amministratore | 29 Carrs Meadow Escrick YO19 6JZ York North Yorkshire | British | 102379260001 | ||||||||||
| GREGSON, Anita Catherine | Amministratore | 5th Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX | United Kingdom | British | 156323460001 | |||||||||
| JENNINGS, Oliver James Wake | Amministratore | 1 Churchill Place EC3P 3AH London | United Kingdom | British | 86815910002 | |||||||||
| JOHNSON, Robert Nigel | Amministratore | 16 Kirkwell Bishopthorpe YO23 2RZ York Yorkshire | United Kingdom | British | 57954340003 | |||||||||
| LEWIS, David Geoffrey | Amministratore | 46 Charles Street CF10 2GE Cardiff Third Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 197786180002 | |||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Amministratore | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| MASON, Geoffrey Keith Howard | Amministratore | Downing House Lower Road SG8 0EG Croydon Royston Cambridgeshire | United Kingdom | British | 37404250003 | |||||||||
| MATTHEWS, Andrew | Amministratore | 1 Churchill Place E14 5HP London Barclays Bank Plc | United Kingdom | British | 82358860003 | |||||||||
| MELLOR, Margaret Louise | Amministratore | 51 Forest Side Chingford E4 6BA London | United Kingdom | British | 80354780001 | |||||||||
| MELLOR, Margaret Louise | Amministratore | 51 Forest Side Chingford E4 6BA London | United Kingdom | British | 80354780001 | |||||||||
| PICKARD, Kim Michele Henrietta | Amministratore | 34 Chalkdown LU2 7FH Luton Bedfordshire | British | 90828960001 | ||||||||||
| SAHEB-ZADHA, Faraidon | Amministratore | 5th Floor 100 Wood Street London EC2V 7EX | England | British | 152128490001 | |||||||||
| WALLACE, Robert Anthony | Amministratore | 1 Castlereagh Wynyard TS22 5QF Billingham Cleveland | England | British | 57589480001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di 2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 Schools Services (Holdings) Limited | 06 apr 2016 | 78 Cannon Street EC4N 6AF London Cannon Place United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
2003 SCHOOLS SERVICES LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Supplemental security agreement | Creato il 29 gen 2005 Consegnato il 08 feb 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become from the company to any senior creditor and 2003 schools services (holdings) limited under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All of its right, title and interest in respect of any amount standing to the credit of trust accounts being, jcuk rhon comp trust ac/no. 58522387 CIN1460595293 and jcuk rhon patc trust ac/no 58522379 cin 1460594891, in, to and under the settlement deed and the net proceeds of any claims, awards and judgements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Borrowers debenture | Creato il 31 mar 2004 Consegnato il 14 apr 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to any senior creditor and holdco on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0