MMS GROUP HOLDINGS LIMITED
Panoramica
Nome della società | MMS GROUP HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Stato della società | Sciolta |
Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
Numero di società | 04514386 |
Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
Data di costituzione | |
Data di cessazione |
Riepilogo
Ha PSCs super sicuri | No |
---|---|
Ha ipoteche | Sì |
Ha una storia di insolvenza | No |
La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di MMS GROUP HOLDINGS LIMITED?
- Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova MMS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Indirizzo della sede legale | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London |
---|---|
Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono le ultime deposizioni per MMS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2013 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Adam Christopher Walker il 01 mar 2013 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Emily Louise Martin il 03 ago 2012 | 2 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2012 con elenco completo degli azionisti | 8 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Stato del capitale al 26 lug 2012
| 4 pagine | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | SH20 | ||||||||||||||
legacy | 2 pagine | CAP-SS | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Rupert John Joseph Hopley il 01 mar 2012 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Nomina di Rupert John Joseph Hopley come amministratore in data 01 nov 2011 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Rachel Elizabeth Jacobs come amministratore in data 16 set 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di John William Burton come amministratore in data 31 ago 2011 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gareth Richard Wright il 19 ago 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2011 con elenco completo degli azionisti | 9 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2010 | 14 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Emily Louise Martin come segretario | 2 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Mark Kerswell come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Peter Stephen Rigby il 05 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Adam Christopher Walker il 05 ott 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Miss Julie Louise Wilson il 27 set 2010 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 ago 2010 con elenco completo degli azionisti | 10 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di MMS GROUP HOLDINGS LIMITED?
Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTIN, Emily Louise | Segretario | 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House United Kingdom | 160700720001 | |||||||
WOOLLARD, Julie Louise | Segretario | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | British | 139159370002 | ||||||
HOPLEY, Rupert John Joseph | Amministratore | 6300 Zug Gubelstrasse 11 Switzerland | Switzerland | British | Solicitor | 164632060002 | ||||
RIGBY, Peter Stephen | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | Company Director | 69164290007 | ||||
WALKER, Adam Christopher | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | Switzerland | British | Finance Director | 129368430003 | ||||
WRIGHT, Gareth Richard | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | Accountant | 131115190002 | ||||
ALLY, Bibi Rahima | Segretario nominato | 60 Harbury Road SM5 4LA Carshalton Beeches Surrey | British | 900024660001 | ||||||
CALLABY, Andrea Mary | Segretario | 5 Thornton Drive CO4 5WB Colchester Essex | British | Company Secretary | 70352690002 | |||||
ELVIN, Christopher | Segretario | 36 Cedar Terrace TW9 2BZ Richmond Surrey | British | Company Director | 82169210001 | |||||
LINDSELL, Philip Edmund | Segretario | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | 101775640001 | ||||||
RICHMOND, Sonia Anna | Segretario | 8 Viscount Gardens KT14 6HE Byfleet Surrey | British | 118535490002 | ||||||
ARORA, Kawaljit Mickey | Amministratore | 9 Emperors Gate SW7 4HH London | British | Company Director | 84366370001 | |||||
BODGER, Stephen Graham | Amministratore | Tanyward House Horsmonden TN12 8JU Tonbridge Kent | United Kingdom | British | Company Director | 68326860001 | ||||
BURTON, John William | Amministratore | Mortimer House 37-41 Mortimer Street W1T 3JH London | United Kingdom | British | General Counsel Lawyer | 113684810001 | ||||
COLLETT, Brian | Amministratore delegato nominato | 254 Old Church Road Chingford E4 8BT London | British | 900024650001 | ||||||
ELVIN, Christopher | Amministratore | 36 Cedar Terrace TW9 2BZ Richmond Surrey | British | Company Director | 82169210001 | |||||
FOYE, Anthony Martin | Amministratore | Lynwood White Lane RG26 5TN Hannington Hampshire | United Kingdom | British | Director | 99515780001 | ||||
GILBERTSON, David Stuart | Amministratore | Casa Maria Spaniard's End Hampstead NW3 7JG London | United Kingdom | British | Company Director | 10921820004 | ||||
JACOBS, Rachel Elizabeth | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | United Kingdom | British | Company Secretary | 92334500004 | ||||
KERSWELL, Mark Henry | Amministratore | 37/41 Mortimer Street W1T 3JH London Mortimer House England | England | British | Director | 82609620003 | ||||
LINDSELL, Philip Edmund | Amministratore | Southside Cottage Stone Lane Axford SN8 2EY Marlborough Wiltshire | British | Chartered Accountant | 101775640001 | |||||
SLADE, Dominic James Haviland | Amministratore | 13 Hasker Street SW3 2LE London | British | Venture Capitalist | 111640410001 | |||||
TER BALKT, Albert Bastiaan | Amministratore | Boomber Glaan 21 Hilversum 1217 Rm The Netherlands | Dutch | Legal Counsel | 82610160001 | |||||
THOMASSON, Jeffrey Scott | Amministratore | 24 Webster Road SE16 4DF London | England | American | Company Secretary | 64473410003 | ||||
WILKINSON, James Henry | Amministratore | 2 The Nursery Sutton Courtenay OX14 4UA Abingdon Oxfordshire | United Kingdom | British | Financial Director | 56006210002 |
MMS GROUP HOLDINGS LIMITED ha ipoteche?
Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Creato il 06 set 2002 Consegnato il 11 set 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to the chargee or any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
|
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0