TRAVELZEST PLC

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTRAVELZEST PLC
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà per azioni
    Numero di società 04520457
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TRAVELZEST PLC?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TRAVELZEST PLC?

    Indirizzo della sede legale
    Grant Thornton Uk Llp 4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TRAVELZEST PLC?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VFB GROUP PLC28 ago 200228 ago 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TRAVELZEST PLC?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 ott 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TRAVELZEST PLC?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TRAVELZEST PLC?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 12 set 2014

    10 pagine2.24B

    Avviso di passaggio da amministrazione a dissoluzione in data 12 set 2014

    10 pagine2.35B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 04 mag 2014

    10 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    34 pagine2.17B

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    11 pagine2.16B

    Indirizzo della sede legale modificato da Farm Cottage Heath House Wedmore Somerset BS28 4UG in data 12 nov 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2013, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 ago 2013

    Stato del capitale al 31 ago 2013

    • Capitale: GBP 2,902,722.2
    SH01

    Cessazione della carica di Jonathan Carroll come amministratore in data 30 lug 2013

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Thomas John Molyneux come amministratore in data 19 apr 2013

    2 pagineTM01

    Bilancio consolidato redatto al 31 ott 2012

    72 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Company business 29/01/2012
    RES13
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Indirizzo della sede legale modificato da 2nd Floor, Delta Place, 27 Bath Road Cheltenham Gloucestershire GL53 7th in data 13 nov 2012

    2 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 28 ago 2012, non è stata fornita alcuna lista dei soci

    8 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Jonathan Carroll il 06 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio consolidato redatto al 31 ott 2011

    73 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11

    Cessazione della carica di James Dominic Brooke come amministratore in data 11 apr 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Jack Fraser come amministratore in data 26 mar 2012

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di John Jack Fraser come amministratore in data 26 mar 2012

    2 pagineTM01

    legacy

    7 pagineMG01

    Nomina di Adrian Cobbold come amministratore in data 09 gen 2012

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di TRAVELZEST PLC?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Segretario
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    British771320001
    COBBOLD, Adrian
    Matheson Boulevard East
    Mississauga
    2350
    Ontario
    Canada
    Amministratore
    Matheson Boulevard East
    Mississauga
    2350
    Ontario
    Canada
    CanadaCanada Uk166995390001
    HALL, Richard Gordon
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    Amministratore
    Farm Cottage
    Heath House
    BS28 4UG Wedmore
    Somerset
    EnglandBritish771320001
    JENKINS, Nigel John
    Old Surrey Hall
    RH19 3PR East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    Amministratore
    Old Surrey Hall
    RH19 3PR East Grinstead
    The Coach House
    West Sussex
    EnglandBritish24257330003
    DAVIES, Dunstana Adeshola
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    Segretario
    20 Northcote Road
    CR0 2HT Croydon
    Surrey
    British55368820001
    SCRIP SECRETARIES LIMITED
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    Segretario
    5th Floor
    17 Hanover Square
    W1S 1HU London
    74920110001
    BROOKE, James Dominic
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Uk
    Amministratore
    Bishopsgate
    EC2M 3AE London
    201
    Uk
    EnglandBritish156641930001
    BRUCE MITFORD, Michael John
    Welsh Newton Common
    NP25 5RR Monmouth
    Newton House
    Gwent
    Amministratore
    Welsh Newton Common
    NP25 5RR Monmouth
    Newton House
    Gwent
    United KingdomBritish84293460004
    CARROLL, Jonathan
    18 Yorkville Ave, Unit 3002
    Toronto
    Ontario M4w 3y8
    Canada
    Amministratore
    18 Yorkville Ave, Unit 3002
    Toronto
    Ontario M4w 3y8
    Canada
    CanadaCanadian119934340001
    CHRYSANTHOU, Chrysanthos Theoclis
    69 Firs Park Avenue
    Winchmore Hill
    N21 2PR London
    Amministratore
    69 Firs Park Avenue
    Winchmore Hill
    N21 2PR London
    British90764380001
    FRASER, John Jack
    Graywood Drive
    Etobicoke
    14
    Ontario M9a 1p6
    Canada
    Amministratore
    Graywood Drive
    Etobicoke
    14
    Ontario M9a 1p6
    Canada
    CanadaCanadian139187050001
    MCKINLAY, Colin Grant
    Crossways Farm
    Nettleden Road
    HP1 3DQ Nettleden
    Hertfordshire
    Amministratore
    Crossways Farm
    Nettleden Road
    HP1 3DQ Nettleden
    Hertfordshire
    British112065020002
    MOLYNEUX, Mark Thomas John
    Rockfield Park
    Rockfield
    NP5 3QB Monmouth
    Gwent
    Amministratore
    Rockfield Park
    Rockfield
    NP5 3QB Monmouth
    Gwent
    British58976290002
    MOTTERSHEAD, Christopher Alan Leigh
    Theccans
    Ringshall
    HP4 1LU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Theccans
    Ringshall
    HP4 1LU Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish144988920001
    ROBB, Nishma
    Flat 13
    40 Eastcote Road
    HA5 1DH Pinner
    Middlesex
    Amministratore
    Flat 13
    40 Eastcote Road
    HA5 1DH Pinner
    Middlesex
    British117867060001
    SMITH, David
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Firley
    17 Highlands Road Sear Green
    HP5 2XL Beaconfield
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish74298510001
    THOMSON, Peter
    23 Fenners Lawn
    Gresham Road
    CB1 2EH Cambridge
    Amministratore
    23 Fenners Lawn
    Gresham Road
    CB1 2EH Cambridge
    British84232180001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001

    TRAVELZEST PLC ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 20 mar 2012
    Consegnato il 28 mar 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) & the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon. It also creates an assignment by the chargor for the purposes of & to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) & interest thereon. Account name barclays bank PLC re travelzest PLC mandatory prepayment account sort code: 20-65-82 account number: 13548465. account name barclays bank PLC re travelzest PLC bms cash cover sort code: 20-65-82 account number: 13483762.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Legal assignment of keyman policy
    Creato il 22 dic 2009
    Consegnato il 30 dic 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any member of the group to the chargee (as agent and trustee for the finance parties) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The keyman policy being the policy of life and critical illness assurance with policy number L0193123333 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security and note pledge agreement
    Creato il 19 giu 2008
    Consegnato il 03 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the secured creditors or any one or more of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The instruments and securities including 7,000,000 ordinary securities in travelzest canco limited, all substitutions and replacements of and increases additions, and accessionss to the property, all proceeds derived from the property, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transazioni
    • 03 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 19 giu 2008
    Consegnato il 26 giu 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the companies or any of them to any finance party or their assignee or successor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 26 giu 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable charge over shares
    Creato il 14 set 2007
    Consegnato il 18 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 18 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable charge over shares
    Creato il 08 ago 2007
    Consegnato il 11 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 11 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable charge over shares
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 21 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The shares and deivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal assignment of key man policies
    Creato il 19 mar 2007
    Consegnato il 21 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Policy no 012259278-5 legal & general mr c mckinley sum assured £1,000,000, policy no 012258792-6 legal & general mr cal mottershead sum assured £1,000,000 and policy no 012259283-5 legal & general mrs nishma robb sum assured £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 21 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable charge over shares
    Creato il 21 dic 2006
    Consegnato il 28 dic 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    100 ordinary shares of £1 each in wow house limited together with any stocks, shares and other securities. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 28 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable share charge
    Creato il 08 nov 2006
    Consegnato il 14 nov 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 14 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Equitable charge over shares
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the shares and derivative assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over cash deposit
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge all the companys rights title interest and benefit in the cash deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security pledge agreement
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    100 common shares and all rights and claims in such securities all substitutions and replacements of increases and additions to the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 16 ott 2006
    Consegnato il 20 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 20 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 ott 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    TRAVELZEST PLC ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    05 nov 2013Inizio dell'amministrazione
    12 set 2014Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Ian James Corfield
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praticante
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0