SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED

SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàSAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04524306
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Resolve Advisory Limited
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 apr 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    11 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 15 gen 2021

    10 pagineLIQ03

    legacy

    5 pagineRP04CS01

    Indirizzo della sede legale modificato da , Westgate Brewery Bury St Edmunds, Suffolk, IP33 1QT, United Kingdom a Resolve Advisory Limited 22 York Buildings London WC2N 6JU in data 28 gen 2020

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 16 gen 2020

    LRESSP

    Stato del capitale al 30 dic 2019

    • Capitale: GBP 1
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Share premium cancelled, amounts arising from reduction credited to p&l reserves 09/12/2019
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2019 con aggiornamenti

    5 pagineCS01
    Note
    DataNota
    31 gen 2020Clarification A second filed CS01 (Statement of capital change) was registered on 31/01/2020.

    Stato del capitale al 03 apr 2019

    • Capitale: GBP 200
    4 pagineSH02

    Bilancio redatto al 29 apr 2018

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Cessazione della carica di Kirk Dyson Davis come amministratore in data 31 gen 2018

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Smothers come amministratore in data 31 gen 2018

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 30 apr 2017

    17 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 04 set 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 01 mag 2016

    17 pagineAA

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 6

    13 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 7

    11 pagineMR05

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata dall'onere 8

    13 pagineMR05

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KESWICK, Lindsay Anne
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    Segretario
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Resolve Advisory Limited
    British92581040002
    SMOTHERS, Richard
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish242658700001
    BACKHOUSE, Nicholas Paul
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    Segretario
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    British64723790002
    LUCK, Richard Nigel
    Herschel Grange
    Warfield
    RG42 6AT Bracknell
    4
    Berkshire
    Segretario
    Herschel Grange
    Warfield
    RG42 6AT Bracknell
    4
    Berkshire
    British61070930001
    NEWHALL NOMINEES LIMITED
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    Segretario
    115 Colmore Row
    B3 3AL Birmingham
    18182520002
    ANAND, Rooney
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    EnglandBritish77808680003
    BACKHOUSE, Nicholas Paul
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    Amministratore
    30 Cathcart Road
    SW10 9NN London
    United KingdomBritish64723790002
    BRIDGE, Timothy John Walter
    Priory Farm
    Shudy Camps
    CB1 6RE Cambridge
    Amministratore
    Priory Farm
    Shudy Camps
    CB1 6RE Cambridge
    United KingdomBritish35576730001
    BRIGGS, Hugh Alexander
    Brick Kiln Cottage Farm
    Berkhamsted Common
    HP4 1PU Berkhamsted
    Hertfordshire
    Amministratore
    Brick Kiln Cottage Farm
    Berkhamsted Common
    HP4 1PU Berkhamsted
    Hertfordshire
    EnglandBritish215065730001
    BROWN, David Anthony
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Amministratore
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    EnglandBritish163139060001
    BROWN, David Anthony
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Amministratore
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    EnglandBritish163139060001
    BULL, Ian Alan
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Amministratore
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    EnglandBritish210299090001
    DAVIS, Kirk Dyson
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    Amministratore
    IP33 1QT Bury St Edmunds
    Westgate Brewery
    Suffolk
    United Kingdom
    United KingdomBritish158484730001
    FEARN, Matthew Robin Cyprian
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    Amministratore
    Westgate Brewery
    Bury St Edmunds
    IP33 1QT Suffolk
    United KingdomBritish109155280002
    FENNEY, Paul Francis
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Porch House
    Church Street Buckden
    PE19 5SX St Neots
    Cambridgeshire
    United KingdomBritish97980790001
    FORRESTER, Karen Martha
    Flat 4 16 Harley Road
    Primrose Hill
    NW3 3BN London
    Amministratore
    Flat 4 16 Harley Road
    Primrose Hill
    NW3 3BN London
    EnglandBritish77261830001
    KING, Christopher
    6 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    Amministratore
    6 Jocelyn Road
    TW9 2TH Richmond
    Surrey
    British77423330001
    LIVINGSTONE, Ian Malcolm
    80h Eaton Square
    SW1W 9AP London
    Amministratore
    80h Eaton Square
    SW1W 9AP London
    British75831270003
    MORSE, Gary John
    44 The Banks
    NN6 7QQ Long Buckby
    Northamptonshire
    Amministratore
    44 The Banks
    NN6 7QQ Long Buckby
    Northamptonshire
    United KingdomBritish95950750001
    PARKER, Raymond
    Wellfield House
    82 High Street, Clayton West
    HD8 9NS Huddersfield
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wellfield House
    82 High Street, Clayton West
    HD8 9NS Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritish86304880001
    PAYNE, Ian Timothy
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    Amministratore
    Rumbolds
    Spring Lane
    SG9 9QH Cottered
    Hertfordshire
    EnglandBritish78974110003
    SHALLOW, Michael St John
    Felsham Hall
    Felsham
    IP30 0QN Bury St Edmunds
    Suffolk
    Amministratore
    Felsham Hall
    Felsham
    IP30 0QN Bury St Edmunds
    Suffolk
    EnglandBritish31387250002

    Chi sono le persone con controllo significativo di SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    06 apr 2016
    Westgate Street
    IP33 1QT Bury St. Edmunds
    Westgate Brewery
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione5265451
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Second supplemental deed of charge
    Creato il 30 giu 2008
    Consegnato il 08 lug 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the properties as specified on the schedule to the form 395 and all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery, book and other debts. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 08 lug 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    First supplemental borrower deed of charge
    Creato il 08 mag 2006
    Consegnato il 19 mag 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the borrower security trustee or any other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of its right title and interest and benefit, present and future (if any), in, to and under: the properties as specified on the schedule to the form 395 and all buildings, trade and other fixtures, fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Trustee (C.I.) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 19 mag 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Deed of charge
    Creato il 07 mar 2005
    Consegnato il 22 mar 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee or any of the other borrower secured creditors on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    1550 abbott redhill f/h SY641089,5350 abingdon arms wantage f/h ON245493,5220 acall estates or interests in such property and all buildings,trade and other fixture,fixed plant and machinery from time to time on such f/h or l/h property,the ancillary property rights, all rights,title,benefit and interest,to and under the relevant documents and the insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc (C.I) Limited (as Borrower Security Trustee)
    Transazioni
    • 22 mar 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 set 2016Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata dall'ipoteca (MR05)
    Twelfth supplemental trust deed supplemental to the trust deed dated 29 july 1991
    Creato il 06 ago 2004
    Consegnato il 13 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £86,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pubco PLC and the Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Trustee)
    Transazioni
    • 13 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third supplemental trust deed supplemental to a trust deed dated 27 may 1997
    Creato il 06 ago 2004
    Consegnato il 13 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £25,000,000.00 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge the undertaking and all its property assets and rights including its uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C. (The Trustee)
    Transazioni
    • 13 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 dic 2002
    Consegnato il 31 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Nomura International PLC (As Security Agent for and on Behalf of the Beneficiaries)(as Defined)
    Transazioni
    • 31 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 ott 2002
    Consegnato il 21 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Blackbirds flitwick high street MK45 1DX t/n BD218853, raby arms hart village hartlepool TS27 3AJ t/n CE157761, tredegar arms newport 4 caerphilly road bassaleg NP1 9LH t/n CYM19458, for details of further properties charged please refer to the form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper Inc. as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 21 ott 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 23 dic 2002Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Third supplemental debenture
    Creato il 06 set 2002
    Acquisito il 07 ott 2002
    Consegnato il 14 ott 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor to the lenders (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Only parts of those assets which are subject to the supplemental debenture and the debenture were acquired by the company; see form 400 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lehman Commercial Paper,Inc. as Agent and Trustee for Itself and Each of the Lenders
    Transazioni
    • 14 ott 2002Registrazione di un'acquisizione (400)
    • 23 dic 2002Dichiarazione che parte o tutta la proprietà di un onere fluttuante è stata liberata (403b)
    • 23 ago 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    SAPPHIRE RURAL DESTINATION NO. 5 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    16 gen 2020Inizio della liquidazione
    24 apr 2022Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Simon Jagger
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    John Addam Street
    WC2N 6JU London
    Ben David Woodthorpe
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London
    Praticante
    22 York Buildings
    WC2N 6JU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0