FOX ENVIRONMENTAL LIMITED

FOX ENVIRONMENTAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàFOX ENVIRONMENTAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04524795
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di FOX ENVIRONMENTAL LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova FOX ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    56 Thornhill Square
    N1 1BE London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di FOX ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per FOX ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021

    5 pagineAA

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 30 set 2020 al 31 mar 2021

    1 pagineAA01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2019

    5 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 lug 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2018

    5 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da 55 Thornhill Square London N1 1BE a 56 Thornhill Square London N1 1BE in data 20 mag 2019

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2017

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2016

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2016 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2015

    3 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 set 2015

    Stato del capitale al 03 set 2015

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2014

    3 pagineAA

    Cessazione della carica di Cyril Henry Flajsner come segretario in data 15 dic 2014

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 set 2014

    Stato del capitale al 08 set 2014

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 set 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 03 set 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 set 2013

    Stato del capitale al 04 set 2013

    • Capitale: GBP 200
    SH01

    Chi sono gli amministratori di FOX ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    KINDER, John Martineau
    3 St Katherine's Precinct
    Outer Circle Regent's Park
    NW1 4HH London
    Amministratore
    3 St Katherine's Precinct
    Outer Circle Regent's Park
    NW1 4HH London
    EnglandBritish1578300002
    FLAJSNER, Cyril Henry
    Algar Road
    Fersfield
    IP22 2BQ Diss
    Algar Barns
    Norfolk
    United Kingdom
    Segretario
    Algar Road
    Fersfield
    IP22 2BQ Diss
    Algar Barns
    Norfolk
    United Kingdom
    British146850670001
    MILLINER, Karen Jayne
    93 Tudor Drive
    KT2 5NP Kingston
    Surrey
    Segretario
    93 Tudor Drive
    KT2 5NP Kingston
    Surrey
    British40044300003
    EDEN SECRETARIES LIMITED
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    Segretario nominato
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    900013460001
    SOVEREIGN SECRETARIES LTD
    Craven Street
    Charing Cross
    WC2N 5NG London
    40
    Segretario
    Craven Street
    Charing Cross
    WC2N 5NG London
    40
    61184470004
    BAILLIE, Edward Blake
    55 Howard Building
    368 Queenstown Road
    SW8 4NN London
    Amministratore
    55 Howard Building
    368 Queenstown Road
    SW8 4NN London
    British10347790006
    BAKER, Donald George
    100 Tolmers Road
    EN6 4JJ Cuffley
    Hertfordshire
    Amministratore
    100 Tolmers Road
    EN6 4JJ Cuffley
    Hertfordshire
    British49971080002
    FULLER, Craig Newton
    Wheelwrights House
    23 Barnsley
    GL7 5EF Cirencester
    Gloucestershire
    Amministratore
    Wheelwrights House
    23 Barnsley
    GL7 5EF Cirencester
    Gloucestershire
    British141269010001
    HAYWARD, Stephen
    2 Kelsall Mews
    Richmond Surrey
    TW9 4BP Kew
    Surrey
    Amministratore
    2 Kelsall Mews
    Richmond Surrey
    TW9 4BP Kew
    Surrey
    British109705520001
    HAYWARD, Stephen
    2 Kelsall Mews
    Richmond Surrey
    TW9 4BP Kew
    Surrey
    Amministratore
    2 Kelsall Mews
    Richmond Surrey
    TW9 4BP Kew
    Surrey
    British109705520001
    LOWDEN, James Patrick Seaward
    The Old Swan House
    Abbotts Ann
    SP11 7BG Andover
    Hampshire
    Amministratore
    The Old Swan House
    Abbotts Ann
    SP11 7BG Andover
    Hampshire
    British96127730001
    GLASSMILL LIMITED
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    Amministratore delegato nominato
    The Quadrant
    118 London Road
    KT2 6QJ Kingston
    Surrey
    900011730001
    MAYFAIR PROPERTIES LIMITED
    40 Craven Street
    Charing Cross
    WC2N 5NG London
    Amministratore
    40 Craven Street
    Charing Cross
    WC2N 5NG London
    97466640001

    Chi sono le persone con controllo significativo di FOX ENVIRONMENTAL LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Mr John Martineau Kinder
    Thornhill Square
    N1 1BE London
    56
    England
    06 apr 2016
    Thornhill Square
    N1 1BE London
    56
    England
    No
    Nazionalità: English
    Paese di residenza: England
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    FOX ENVIRONMENTAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 05 gen 2010
    Consegnato il 21 gen 2010
    In corso
    Importo garantito
    £2,025,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    45 clarges street london.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Private Bank (UK) Limited
    Transazioni
    • 21 gen 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 gen 2007
    Consegnato il 30 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 30 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 19 gen 2007
    Consegnato il 30 gen 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    45 clarges street london floating charge all unattached plant machinery and chattels.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland (Ireland) Limited
    Transazioni
    • 30 gen 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage by way of specific legal charge
    Creato il 04 apr 2006
    Consegnato il 20 apr 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that land and buildings situated at and known as 45 clarges street, london t/no LN130940.
    Persone aventi diritto
    • Tracktower Limited
    Transazioni
    • 20 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage
    Creato il 11 mar 2004
    Consegnato il 17 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all that land and buildings situate at and k/a 45 clarges street, mayfair, london t/n LN130940.
    Persone aventi diritto
    • Kingsway Equity Finance Limited
    Transazioni
    • 17 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 23 feb 2004
    Consegnato il 26 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Business Finance Limited
    Transazioni
    • 26 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 feb 2004
    Consegnato il 26 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and premises known as 45 clarges street london W1J 7ER t/n LN130940. All undertaking and goodwill.
    Persone aventi diritto
    • Business Finance Limited
    Transazioni
    • 26 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 ago 2004Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 17 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    • 04 feb 2006Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (405 (2))
      • Numero di pratica 1
    Floating charge
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 26 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking & all its property, assets, rights & income whatsoever & wheresoever both present & future.
    Persone aventi diritto
    • Global Equity Finance Limited
    Transazioni
    • 26 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 26 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The f/h property known as 45 clarges street london t/n LN130940. By way of first fixed charge all the goodwill, all plant & machinery, computers & office & other equipment now & in the future at the property. All benefits in respect of insurances. All its rights in & to any licence held by the company.
    Persone aventi diritto
    • Global Equity Finance Limited
    Transazioni
    • 26 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second legal charge
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 20 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage the f/h property known as 45 clarges street, london t/no LN30940; all and any proceeds of sale; all plant fixtures machinery fittings and equipment from time to time on the property;. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bridges Finance Limited
    Transazioni
    • 20 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    FOX ENVIRONMENTAL LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    23 feb 2004Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Anthony Anderson Jeffs
    Anderson House
    60-62 Regent Street
    CV32 5EG Leamington Spa
    Warwickshire
    Praticante
    Anderson House
    60-62 Regent Street
    CV32 5EG Leamington Spa
    Warwickshire
    2
    DataTipo
    22 set 2005Fine dell'amministrazione
    23 set 2004Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geoffrey Robbins
    Cba
    Lichfield Place
    B6 7SS 435 Lichfield Road
    Aston Birmingham
    Praticante
    Cba
    Lichfield Place
    B6 7SS 435 Lichfield Road
    Aston Birmingham
    Neil Charles Money
    39 Castle Street
    LE1 5WN Leicester
    Praticante
    39 Castle Street
    LE1 5WN Leicester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0