DEDMERE MANAGEMENT LIMITED

DEDMERE MANAGEMENT LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDEDMERE MANAGEMENT LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04528424
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Integrity House Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Buckinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INTEGRITY SOFTWARE LIMITED14 nov 200214 nov 2002
    BROOMCO (3025) LIMITED06 set 200206 set 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 gen 2016

    Quali sono le ultime deposizioni per DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Bilancio redatto al 31 gen 2016

    21 pagineAA

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Dichiarazione di conformità presentata il 06 set 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 dic 2015 al 31 gen 2016

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    18 pagineAA

    Cessazione della carica di Niall Anthony Keating come amministratore in data 23 feb 2016

    1 pagineTM01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 06 set 2015 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital29 set 2015

    Stato del capitale al 29 set 2015

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stewart Holness il 29 set 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Joseph James Hanly il 29 set 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Joseph James Hanly il 29 set 2015

    1 pagineCH03

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed integrity software LIMITED\certificate issued on 08/04/15
    3 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 gen 2015

    RES15

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 30 gen 2015

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Soddisfazione dell'onere 3 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    6 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    6 pagineMR04

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 30 gen 2015

    • Capitale: GBP 100.00
    4 pagineSH19

    Chi sono gli amministratori di DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HANLY, Joseph James
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Segretario
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Irish293898290001
    HANLY, Joseph James
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    EnglandIrish293898290001
    HOLNESS, Stewart George
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    EnglandBritish97855450001
    HOWELL, Mark
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Segretario
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Irish139936240001
    HOWELL, Mark
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Segretario
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Irish139936240001
    MACARI, Mario
    23 Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    Segretario
    23 Yellow Walls Road
    IRISH Malahide
    Co Dublin
    Ireland
    British85747410001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Segretario nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001
    BERGIN, John
    15 Duncarrig
    IRISH Sutton
    Dublin 13
    Ireland
    Amministratore
    15 Duncarrig
    IRISH Sutton
    Dublin 13
    Ireland
    Irish85747470001
    BUTLER, Ken
    Woodside
    41 Flemish Place
    RG42 2FG Warfield
    Berkshire
    Amministratore
    Woodside
    41 Flemish Place
    RG42 2FG Warfield
    Berkshire
    British87335180001
    DENLEY, Gareth
    1 1 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    1 1 Boundary Park
    KT13 9RR Weybridge
    Surrey
    British108214220001
    EPSTEIN, Ivan Michael
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Buckinghamshire
    South African93783520001
    HOWELL, Mark
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    Amministratore
    Woodfield
    Rathfarnham
    Dublin 16
    49
    Ireland
    IrelandIrish139936240001
    KEATING, Niall Anthony
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Mere Park
    Dedmere Road
    SL7 1PB Marlow
    Integrity House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    IrelandIrish189714280001
    LUCKETT, Jeremy Kimber
    Hustings House
    Carlesgill Place
    RG9 1NY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Amministratore
    Hustings House
    Carlesgill Place
    RG9 1NY Henley On Thames
    Oxfordshire
    United KingdomBritish112642730001
    NAGEL, Paul
    6 Loughborough Gate
    Loughborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    6 Loughborough Gate
    Loughborough Lane
    HP9 2DQ Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Irish87337070001
    NAGLE, Patrick Gabriel
    Framewood Manor
    Framewood Road
    SL2 4QR Fulmer
    Bucks
    Amministratore
    Framewood Manor
    Framewood Road
    SL2 4QR Fulmer
    Bucks
    British101646030001
    NAGLE, Peter David
    44 Burkes Road
    HP9 1PN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Amministratore
    44 Burkes Road
    HP9 1PN Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandIrish58907400003
    DLA NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016450001
    DLA SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    Amministratore delegato nominato
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    900016460001

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per DEDMERE MANAGEMENT LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    06 set 2016La società sa o ha ragione di credere che vi sia una persona registrabile in relazione alla società, ma non l'ha identificata.

    DEDMERE MANAGEMENT LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Charge over shares
    Creato il 30 giu 2011
    Consegnato il 07 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The shares in premier software limited and the derivative assets, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 05 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 30 giu 2011
    Consegnato il 07 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 07 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 set 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 05 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security confirmation deed
    Creato il 18 dic 2009
    Consegnato il 30 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Secured sums & secured liabilities see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the mezzanine finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of legal mortgage all land. By way of fixed charge all land and other land all plant and machinery all rental and other income and all debts all securities all insurance and assurance contracts and policies all goodwill and uncalled share capital all intellectual property and the benefit of all agreements. By way of floating charge all assets which are not effectively charged. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management Limited (The Mezzanine Security Agent)
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 03 set 2014Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 05 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A charge over intellectual property
    Creato il 20 lug 2005
    Consegnato il 05 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to the mezzanine finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of fixed charge all right title interest and benefit in and to all scheduled intellectual property, all other intellectual property, royalties and each royalties account. By way of floating charge the secured assets which are not effectively subject to any fixed charge. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Graphite Capital Management Limited (The Mezzanine Security Agent)
    Transazioni
    • 05 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 lug 2005
    Consegnato il 29 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over intellectual property
    Creato il 20 lug 2005
    Consegnato il 29 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First fixed charge all the company's present and future right,title,interest and benfit in and to all the scheduled intellectual property and all other intellectual property and the royalties. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 lug 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0