MOTORSTEP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMOTORSTEP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04532029
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di MOTORSTEP LIMITED?

    • Gestione di immobili per conto terzi (68320) / Attività immobiliari

    Dove si trova MOTORSTEP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    5th Floor Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MOTORSTEP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per MOTORSTEP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2020

    25 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 set 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Nomina di Mr Paul Simon Kent Wright come segretario in data 05 gen 2021

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di Nexus Management Services Limited come segretario in data 05 gen 2021

    1 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2019

    23 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 set 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2018

    22 pagineAA

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    21 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 23 ago 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Memorandum e Statuto

    11 pagineMA

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Amendment and restatement agreement 03/05/2018
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Iscrizione dell'ipoteca 045320290006, creata il 08 mag 2018

    42 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Nomina di Mr David Christopher Austin come amministratore in data 01 apr 2017

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Timothy David Walker-Arnott come amministratore in data 01 apr 2017

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip John Holland come amministratore in data 01 apr 2017

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Richard Howell come amministratore in data 01 apr 2017

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Philip John Holland il 08 lug 2016

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    19 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di MOTORSTEP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WRIGHT, Paul Simon Kent
    Greener House Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Segretario
    Greener House Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    278804090001
    AUSTIN, David Christopher
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritishChartered Surveyor131339590001
    HOWELL, Richard
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    EnglandBritishAccountant164790590001
    HYMAN, Harry Abraham
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Amministratore
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    United KingdomBritishChartered Accountant35560380001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Segretario
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    BritishDirector35427700001
    BURNHOPE, Celia
    Mayors Walk Close
    WF8 2SP Pontefract
    3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Segretario
    Mayors Walk Close
    WF8 2SP Pontefract
    3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    BritishPractice Manager84996750004
    NEXUS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Segretario
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione4187765
    57253330002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    AGARWALA, Jyoti Kumar
    35 Edgefold Road
    Worsley
    M28 7GE Manchester
    Amministratore
    35 Edgefold Road
    Worsley
    M28 7GE Manchester
    BritishDoctor85520660001
    BAKER, Sarah, Reverand Doctor
    12 Ingswell Drive
    Notton
    WF4 2NF Wakefield
    West Yorkshire
    Amministratore
    12 Ingswell Drive
    Notton
    WF4 2NF Wakefield
    West Yorkshire
    BritishDoctor85520730001
    BURGESS, Richard John
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    Amministratore
    54 Manor Road
    SM2 7AG Cheam
    Surrey
    United Kingdom ( England ) (Gb-Eng)BritishDirector35427700001
    BURNHOPE, Celia
    Mayors Walk Close
    WF8 2SP Pontefract
    3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Mayors Walk Close
    WF8 2SP Pontefract
    3
    West Yorkshire
    United Kingdom
    BritishPractice Manager84996750004
    GODRIDGE, Anne Carol, Doctor
    6 Ridgedale Mount
    WF8 1SB Pontefract
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Ridgedale Mount
    WF8 1SB Pontefract
    West Yorkshire
    BritishDoctor85520790001
    HAMBRO, James Daryl
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Amministratore
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    UkBritishCompany Director152563890001
    HEWITT, Deborah Frances, Dr
    37 Baronsway
    LS15 7AW Leeds
    Yorkshire
    Amministratore
    37 Baronsway
    LS15 7AW Leeds
    Yorkshire
    BritishDoctor96800130001
    HOLLAND, Philip John
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    Amministratore
    Greener House
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor
    England
    England
    EnglandBritishChartered Accountant163838050001
    HUNTER, Christine
    6 Bronte Rise
    WF10 3TU Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    6 Bronte Rise
    WF10 3TU Castleford
    West Yorkshire
    BritishNurse85520620001
    MARSDEN, Graham Thomas
    Frog Grove House, Frog Grove Lane
    Wood Street Village
    GU3 3HE Guildford
    Surrey
    Amministratore
    Frog Grove House, Frog Grove Lane
    Wood Street Village
    GU3 3HE Guildford
    Surrey
    EnglandBritishChartered Surveyor66512500001
    SLOAN, Richard Ernest George, Dr
    Hill House,
    Airedale Drive, Airedale
    WF10 2QT Castleford
    West Yorkshire
    Amministratore
    Hill House,
    Airedale Drive, Airedale
    WF10 2QT Castleford
    West Yorkshire
    EnglandBritishDoctor84996920003
    SMITH, Monica, Doctor
    15 Wakefield Road
    LS25 1AN Garforth
    West Yorkshire
    Amministratore
    15 Wakefield Road
    LS25 1AN Garforth
    West Yorkshire
    BritishDoctor85520590001
    VAUGHAN, Helen Margaret
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Amministratore
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    UkBritishChartered Accountant152564380001
    WALKER-ARNOTT, Timothy David
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    Amministratore
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Ground Floor Ryder Court
    EnglandBritishChartered Surveyor131266520001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di MOTORSTEP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Health Investments Limited
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    01 giu 2016
    66-68 Haymarket
    SW1Y 4RF London
    5th Floor, Greener House
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Acts 2006
    Luogo di registrazioneEngland & Wales
    Numero di registrazione04301986
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    MOTORSTEP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 08 mag 2018
    Consegnato il 14 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    Land on the north west side of park dale, castleford and tieve tara medical centre, park dale, castleford. For more details please refer to the instrument.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Aviva Public Private Finance Limited
    Transazioni
    • 14 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Deed of assignment
    Creato il 23 dic 2008
    Consegnato il 03 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from health investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the rights titles benefits and interests whether present or future of the company to all moneys from time to time due owing or incurred to the company under the lease in respect of all that f/h land and buildings being tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK762429, WYK343515, WYK352652 all that good l/h land and buildings being tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK890110, all that f/h land and buildings being tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK159986, all that possessory land and buildings being part of tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK893567 other than sums receivable by the company by way of insurance contributions service charge payments to sinking funds or any vat payable thereon (rents) including the right to receive the same and the full benefit of any guarantee or security for the performance thereof now or at any time hereafter given together with all claims causes of action and damages arising in connection therewith and proceeds of the foregoing are assigned to the trustee (the assigned rights).
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Supplemental deed
    Creato il 23 dic 2008
    Consegnato il 03 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from health investments limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property all that f/h land and buildings being tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK762429, WYK343515, WYK352652 all that good l/h land and buildings being tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK890110, all that f/h land and buildings being tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK159986, all that possessory land and buildings being part of tieve tara medical centre parkdale airedale castleford west yorkshire t/no. WYK893567 including all buildings erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenant's fixtures) and fixed plant and machinery for the time being thereon and all improvements and additions thereto and all easements rights and licences appurtenant thereto subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but otherwise free from encumbrance all moneys from time to time deposited with the trustee on the terms set out in schedule 6 to the principal deed.
    Persone aventi diritto
    • The General Practice Finance Corporation Limited
    Transazioni
    • 03 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignment by way of security contract
    Creato il 11 gen 2005
    Consegnato il 21 gen 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All of the right title and interest under the contract all moneys from time to time payable together with any proceeds of any insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 04 mar 2004
    Consegnato il 09 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The properties known as park dale airedale castleford and tieve tara surgery airedale drive airedale t/ns WYK352652 and WYK343515. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 dic 2003
    Consegnato il 10 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 10 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0