RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED
Panoramica
| Nome della società | RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04547927 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
- Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni
Dove si trova RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 1st Floor Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester Lancashire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| ING RED UK (ROYAL MILLS) LTD | 27 nov 2003 | 27 nov 2003 |
| LONDON & AMSTERDAM DEVELOPMENTS (ANCOATS) LIMITED | 27 set 2002 | 27 set 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2022 |
Quali sono le ultime deposizioni per RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 1 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2022 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2021 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Esercizio contabile in corso abbreviato dal 31 dic 2020 al 31 mar 2020 | 1 pagine | AA01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2019 | 8 pagine | AA | ||||||||||
Cessazione della carica di Michael Shaw come segretario in data 18 nov 2019 | 1 pagine | TM02 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2019 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2018 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2017 | 6 pagine | AA | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Daren Whitaker il 06 feb 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Daren Whitaker il 30 gen 2018 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2016 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 09 ott 2016 con aggiornamenti | 5 pagine | CS01 | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2015 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 09 ott 2015 con elenco completo degli azionisti | 5 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2014 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 dic 2013 | 7 pagine | AA | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WHITAKER, Daren | Amministratore | Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester 1st Floor Lancashire England | England | British | 177268740005 | |||||
| COETZEE, Russell Steven | Segretario | 64 Ellerdale Street SE13 7JU London | British | 102287620001 | ||||||
| KHANAM, Samia | Segretario | 216 Lonsdale Avenue East Ham E6 3PP London | British | 78775890001 | ||||||
| MEAD, Stefan | Segretario | 82a Aslett Street SW18 2BQ London | British | 142492700001 | ||||||
| SHAW, Michael | Segretario | Floor Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester 1st Lancashire England | 174853240001 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALKER, David | Amministratore | Ludlow Avenue LU1 3RW Luton 16 Bedfordshire United Kingdom | England | British | 79215690001 | |||||
| BRAND, Hein Jacobus Pieter Willem | Amministratore | Zuider Stationsweg 2061 HE Bloemendaa 2a Netherlands | Netherlands | Dutch | 165629010001 | |||||
| COETZEE, Russell Steven | Amministratore | 64 Ellerdale Street SE13 7JU London | England | British | 102287620001 | |||||
| HOEKSMA, Siep | Amministratore | Spade 47 Da Wieringerwerf Nh 1771 The Netherlands | Dutch | 56665150002 | ||||||
| KOOIJ, Marcel Antonius | Amministratore | The Rise TN13 1RY Sevenoaks 55 Kent United Kingdom | United Kingdom | Dutch | 127713020003 | |||||
| MATHIJSSEN, Sven Petrus Johannes Maria | Amministratore | Senecalaan 20 Zeist 3707 Zn The Netherlands | Netherlands | Dutch | 124390040001 | |||||
| PARKER, Guy Trevor | Amministratore | Cann Lane North Woodside Mews WA4 5NF Appleton Warrington Caxton House | England | British | 130108080001 | |||||
| PEARCE, Ian George Stanforth | Amministratore | The Bell House Crowbrook Road, Askett HP27 9LS Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | United Kingdom | 2585440004 | |||||
| RAINFORD, Benedict John | Amministratore | 5 Woodstock Road North AL1 4QB St. Albans Hertfordshire | United Kingdom | British | 54428250002 | |||||
| TAYLOR, Martin Laurence | Amministratore | 20 Bushwood Road Kew TW9 3BQ Richmond Surrey | England | British | 6069400002 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paragon Developments (Manchester) Limited | 06 apr 2016 | Nq Building 47 Bengal Street M4 6BB Manchester 1st Floor Lancashire England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
RM DEVELOPMENTS (MANCHESTER) LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 05 lug 2013 Consegnato il 24 lug 2013 | In corso | ||
Breve descrizione Kennedy building paragon mill and royal mill being land and buildings at henry street jersey street and redhill street ancoats manchester t/no MAN204533 and part only t/no GM974265. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Legal mortgage and debenture | Creato il 12 ago 2004 Consegnato il 31 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first charge all plant and machinery all computers vehicles office equipment and other equipment the benefit of all contracts licences and warranties by way of first floating charge all its present and future assets and undertaking. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Charge over bank accounts | Creato il 12 ago 2004 Consegnato il 31 ago 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari By way of first fixed charge all its right title and interest in the accounts and the charged balance the accounts being the sales proceeds account development expenditure account numbered 10105643 sort code 20-65-63 and designated ing red UK (royal mills)sales proceeds account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0