MARBLESPIRE LIMITED

MARBLESPIRE LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàMARBLESPIRE LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione controllata
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04566539
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di MARBLESPIRE LIMITED?

    • (7011) /
    • (7487) /

    Dove si trova MARBLESPIRE LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Southbank
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St Annes
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di MARBLESPIRE LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2006
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 gen 2007
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2005

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per MARBLESPIRE LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al18 ott 2016
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma01 nov 2016
    Scaduto

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per MARBLESPIRE LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per MARBLESPIRE LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 03 dic 2012

    2 pagine3.6

    legacy

    2 pagineLQ02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 ott 2012

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 apr 2012

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 ott 2011

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 apr 2010

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 apr 2011

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 ott 2010

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 ott 2009

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 apr 2009

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 20 mag 2009

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine405(2)

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 17 apr 2009

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 31 gen 2009

    1 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 27 gen 2009

    2 pagine3.6

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine405(1)

    legacy

    1 pagine405(1)

    legacy

    1 pagine405(1)

    legacy

    2 pagine405(1)

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    7 pagine395

    legacy

    9 pagine395

    legacy

    2 pagine363a

    Chi sono gli amministratori di MARBLESPIRE LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CURRIE, Andrew Douglas
    Southbank
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    Segretario
    Southbank
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham St. Annes
    Lancashire
    British54591040005
    PHILBIN, Kevin
    28 Dingle Road
    Middleton
    M24 1NH Manchester
    Segretario
    28 Dingle Road
    Middleton
    M24 1NH Manchester
    British95735720001
    SLEATH, David Antony Heathcote
    2 Higher Fold View Barns
    Rainow Road
    SK10 2PF Macclesfield
    Cheshire
    Segretario
    2 Higher Fold View Barns
    Rainow Road
    SK10 2PF Macclesfield
    Cheshire
    British114023280001
    SECRETARIAL APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Segretario nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017270001
    WACKS CALLER LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Segretario
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    58396030003
    CURRIE, Martine
    Southbank
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham
    Lancashire
    Amministratore
    Southbank
    4 Clifton Drive
    FY8 5PP Lytham
    Lancashire
    British104226910001
    PHILBIN, Kevin
    28 Dingle Road
    Middleton
    M24 1NH Manchester
    Amministratore
    28 Dingle Road
    Middleton
    M24 1NH Manchester
    United KingdomBritish95735720001
    SLEATH, David Antony Heathcote
    2 Higher Fold View Barns
    Rainow Road
    SK10 2PF Macclesfield
    Cheshire
    Amministratore
    2 Higher Fold View Barns
    Rainow Road
    SK10 2PF Macclesfield
    Cheshire
    British114023280001
    CORPORATE APPOINTMENTS LIMITED
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    Amministratore delegato nominato
    16 Churchill Way
    CF10 2DX Cardiff
    900017260001
    WACKS CALLER (NOMINEES) LIMITED
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    Amministratore
    Wacks Caller Steam Packet House
    76 Cross Street
    M2 4JU Manchester
    77050230003

    MARBLESPIRE LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 11 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    43 brookside close west derby merseyside t/no MS166878,45 brookside close west derby merseyside t/no MS166888,47 brookside close west derby merseyside t/no MS166887 (for details of further properties charged please refer to form 395) any goodwill,all present and future plant,machinery and other items on or attached to and forming of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pricapita Limited
    Transazioni
    • 11 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2008Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
      • Numero di pratica 1
    Debenture
    Creato il 31 ago 2007
    Consegnato il 11 set 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    43 brookside close west derby merseyside t/no MS166878 (for details of further properties charged please refer to form 3. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Pricapita Limited
    Transazioni
    • 11 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 dic 2005
    Consegnato il 22 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    £1,775,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    1.All that land and buildings situate at and k/a land and buildings at brookside close liverpool for further details of properties charged please refer to the form 395 2. 1 and 2 edenfield cottages and 1 and 2 mews cottages clifton drive lytham st annes lancashire t/n LAN5195 and LAN5195 3. land and buildings at clifton drive lytham st annes lancashire t/n LAN5193 and LAN5192 and LAN5191. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Anglo Eastern Trust Limited
    Transazioni
    • 22 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 apr 2008Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
    • 404 dic 2012Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 4
    Mortgage debenture
    Creato il 01 dic 2005
    Consegnato il 07 dic 2005
    In corso
    Importo garantito
    £45,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    All that land and buildings situate at and k/a land forming part of edenfield, clifton drive, lytham st annes t/no LAN5193, LAN5192 & LAN5191. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Affirmitive Finance Limited
    • Affirmative Finance Limited
    Transazioni
    • 07 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2008Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
      • Numero di pratica 3
    Mortgage debenture
    Creato il 07 ott 2005
    Consegnato il 21 ott 2005
    In corso
    Importo garantito
    £630,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    F/H all that land & buildings situate and known as edenfield cottages clifton drive lytham st annes lancashire t/no LAN5194.
    Persone aventi diritto
    • Affirmative Finance Limited
    Transazioni
    • 21 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 06 feb 2008Nomina di un amministratore o gestore (405 (1))
      • Numero di pratica 2
    Legal charge
    Creato il 10 ago 2005
    Consegnato il 24 ago 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £299,000.00 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    F/H land forming part of edenfield clifton drive lytham st annes t/no LAN5194.
    Persone aventi diritto
    • Mortgage Guarantee PLC
    Transazioni
    • 24 ago 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 apr 2005
    Consegnato il 22 apr 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £2,450,000.00 due or to become due from the company to
    Brevi particolari
    The land and buildings k/a edenfield, clifton drive, lytham st annes lancashire.
    Persone aventi diritto
    • Goldentree Financial Services Limited
    Transazioni
    • 22 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 23 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Freehold property k/a "edenfield" clifton drive lytham st annes t/n LA713272.
    Persone aventi diritto
    • Furnishing Trades Benevolent Association
    Transazioni
    • 23 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 mar 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 13 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 12 set 2003
    Consegnato il 13 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a edenfield clifton drive lytham st annes t/n LA713272. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 ago 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    MARBLESPIRE LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    31 ago 2007Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Nicholas Andrew Hancock
    Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Praticante
    Uhy Hacker Young
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Robert Edward Caunce Cook
    Hacker Young And Ptnrs
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    Praticante
    Hacker Young And Ptnrs
    St James Building
    M1 6HT 79 Oxford Street
    Manchester
    2
    DataTipo
    07 ott 2005Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Kevin Lucas
    Ideal Corporate Solutions
    Lakeside House
    BL3 2QJ Waterside Business Park
    Smiths Road Bolton
    Praticante
    Ideal Corporate Solutions
    Lakeside House
    BL3 2QJ Waterside Business Park
    Smiths Road Bolton
    Andrew David Rosler
    Lakeside House
    Waterside Business Park
    Smiths Road
    Bolton Bl3 2qr
    Praticante
    Lakeside House
    Waterside Business Park
    Smiths Road
    Bolton Bl3 2qr
    3
    DataTipo
    01 dic 2005Data dello strumento
    Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Andrew David Rosler
    Lakeside House
    Waterside Business Park
    Smiths Road
    Bolton Bl3 2qr
    Praticante
    Lakeside House
    Waterside Business Park
    Smiths Road
    Bolton Bl3 2qr
    Kevin Lucas
    Ideal Corporate Solutions
    Lakeside House
    BL3 2QJ Waterside Business Park
    Smiths Road Bolton
    Praticante
    Ideal Corporate Solutions
    Lakeside House
    BL3 2QJ Waterside Business Park
    Smiths Road Bolton
    4Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jeremy Paul David Oddie
    Mitchell Charlesworth Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3WR Manchester
    Ricevitore/gestore
    Mitchell Charlesworth Centurion House
    129 Deansgate
    M3 3WR Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0