E REALISATIONS 2020 LIMITED

E REALISATIONS 2020 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Dichiarazione di conferma
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàE REALISATIONS 2020 LIMITED
    Stato della societàIn amministrazione
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04566809
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione

    Qual è lo scopo di E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    • Vetrate (43342) / Costruzioni

    Dove si trova E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    EVEREST LIMITED01 mag 200301 mag 2003
    EVER 1950 LIMITED18 ott 200218 ott 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Scaduto
    Prossimi bilanci
    Fine del prossimo esercizio al31 mar 2020
    Scadenza dei prossimi bilanci il31 mar 2021
    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2018

    Qual è lo stato dell'ultima dichiarazione di conferma per E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Scaduto
    Ultima dichiarazione di conferma redatta al18 ott 2020
    Scadenza della prossima dichiarazione di conferma29 nov 2020
    Ultima dichiarazione di conferma
    Prossima dichiarazione di conferma redatta al18 ott 2019
    Scaduto

    Quali sono le ultime deposizioni per E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    15 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    31 pagineAM10

    Avviso di proroga del periodo dell'amministrazione

    3 pagineAM19

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore

    30 pagineAM10

    Cessazione della carica di John Bostock come amministratore in data 14 ago 2020

    1 pagineTM01

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    3 pagineAM06

    Dichiarazione delle attività con il modulo AM02SOA

    14 pagineAM02

    Indirizzo della sede legale modificato da Everest House Sopers Road, Cuffley Potters Bar Hertfordshire EN6 4SG a 2nd Floor 110 Cannon Street London EC4N 6EU in data 06 lug 2020

    2 pagineAD01

    Risoluzioni

    Resolutions
    3 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 09 giu 2020

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    60 pagineAM03

    Nomina di un amministratore

    3 pagineAM01

    Dettagli del segretario cambiati per Estera Administration (Uk) Limited il 01 apr 2020

    1 pagineCH04

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    Chi sono gli amministratori di E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    OCORIAN ADMINISTRATION (UK) LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28 Eastcastle Street
    England
    Segretario
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28 Eastcastle Street
    England
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione07473349
    174130020003
    LEIGHTON, Richard Mathieu
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    EnglandDutch183503870001
    JARMAN, Simon James
    1 Swanley Bar Lane
    EN6 1NN Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    1 Swanley Bar Lane
    EN6 1NN Potters Bar
    Hertfordshire
    British65100170002
    SMETHURST, Edward Gerald
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    United Kingdom
    Segretario
    Salthill Road
    BB7 1PE Clitheroe
    Enterprise Works
    Lancashire
    United Kingdom
    British86741880002
    WARWICK-SAUNDERS, Richard Meirion
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Segretario
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    168812940001
    EVERSECRETARY LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Segretario nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023530001
    HERITAGE ADMINISTRATION SERVICES LIMITED
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    Segretario
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27/28
    England
    174130020001
    ASPLIN, Robert Alexander
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish149870270004
    BLAND, Duncan
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritish87382460002
    BOSTOCK, John
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    2nd Floor
    United KingdomBritish27964350001
    DAYAN, Daniel Alexander
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish114867990002
    EADY, Roy Thomas
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    Amministratore
    Maylands Mill Hill
    Shenfield
    CM15 8EU Brentwood
    Essex
    EnglandBritish3078230001
    FAWCETT, Christopher Stephen
    86 Kings Road
    TW10 6EE Richmond
    Surrey
    Amministratore
    86 Kings Road
    TW10 6EE Richmond
    Surrey
    British81019930002
    FROST, Roy Anthony
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritish169351970001
    GARDINER, Stephen James Furse
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Gb-EngBritish76915750003
    HOLLAND, Joanne Maria
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandAustralian74549980001
    HOPLEY, Mark Simon Griffith
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    EnglandBritish105670800002
    JARMAN, Simon James
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish65100170002
    JORDAN, Alan James
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandIrish150320720001
    LAMBERT, Andrew Alan
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish163093150001
    LEIGHTON, Richard Mathieu
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandDutch183503870005
    MCGRATH, William Brendan
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish9583140003
    MOTTERSHEAD, Peter David Leigh
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish102140470001
    MUNNS, Karl Sean
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandBritish233273680001
    PARSELL, Antony Clive
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    EnglandEnglish76298010001
    RISLEY, Gary Alexander
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    Amministratore
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish170454400001
    SANDERS, Nicholas Ian Burgess
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish83283880002
    SAUNDERS, Roy
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish144563690001
    STANWAY, Andrew David
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United Kingdom British 31199160002
    TROUGHTON, Martin
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish146281880001
    WILLIAMSON, Peter John
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish152256060003
    WOLSTENHOLME, Adrian John
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    Amministratore
    Everest House
    Sopers Road, Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Hertfordshire
    United KingdomBritish130602430004
    EVERDIRECTOR LIMITED
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    Amministratore delegato nominato
    Eversheds House
    70 Great Bridgewater Street
    M1 5ES Manchester
    900023520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di E REALISATIONS 2020 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Sopers Road
    Cuffley
    EN6 4SG Potters Bar
    Everest House
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione08004858
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    E REALISATIONS 2020 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 09 mag 2018
    Consegnato il 22 mag 2018
    In corso
    Breve descrizione
    F/H land at treherbert industrial estate rhondda south wales t/no WA244458 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited in Its Capacity as General Partner of BECAP12 Gp LP in Its Capacity as General Partner of Becap 12 Fund LP
    Transazioni
    • 22 mag 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 27 mar 2015
    Consegnato il 08 apr 2015
    In corso
    Breve descrizione
    Land at treherbert industrial estate treherbert treorchy t/no WA244458.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC (As Security Trustee for the Secured Parties)
    Transazioni
    • 08 apr 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 19 giu 2012
    Consegnato il 28 giu 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H treherbert industrial estate, rhondda, south wales, t/no: wa 244458. l/h unit 7, north orbital commercial park, hertfordshire, t/no: HD438566; and l/h everest house sopers road, cuffley, potters bar, t/no: HD477923. (For details of all other property charged, please refer to the MG01 document). Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Gp Limited
    Transazioni
    • 28 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 25 apr 2012
    Consegnato il 30 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • BECAP12 Fund LP
    Transazioni
    • 30 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 giu 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2012
    Consegnato il 11 apr 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 11 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 08 nov 2011
    Consegnato il 21 nov 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any one or more of the principals or the companies to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account whether in sterling or any other currency or currency unit and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 nov 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Chattel mortgage
    Creato il 29 apr 2009
    Consegnato il 01 mag 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Jcb c/w 9" 12" & dm buckets. Cd summer electrical x 14 high bay lights 400W metal handle fitting. Rojak design x 50 stopper foot/extender left (for details of further chattels charged please refer to form 395) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lombard North Central PLC
    Transazioni
    • 01 mag 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 set 2007
    Consegnato il 14 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and the Othersecured Parties (The Security Agent)
    Transazioni
    • 14 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of deposit
    Creato il 14 apr 2005
    Consegnato il 16 apr 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Rent deposit balance (initial amount £17,670) and accrued interest.
    Persone aventi diritto
    • Coal Pension Properties Limited
    Transazioni
    • 16 apr 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Chattel mortgage
    Creato il 28 nov 2003
    Consegnato il 09 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All of the right title and interest from time to time of the company in the equipment specified in the schedule to the mortgage.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 09 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 25 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H treherbert industrial estate treherbert mid glam t/n WA244458. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 25 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 17 apr 2003
    Consegnato il 25 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland(As Security Trustee for the Security Beneficiaries) (Security Trustee)
    Transazioni
    • 25 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 15 set 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    E REALISATIONS 2020 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    08 giu 2020Inizio dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Geoffrey Paul Rowley
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Alastair Massey
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Praticante
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0