ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED

ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale
    Numero di società 04568235
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED?

    • Attività di organizzazioni di categoria di imprenditori e datori di lavoro (94110) / Altre attività di servizi

    Dove si trova ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Leytonstone House Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Jeffrey William Somerfield il 01 mag 2022

    1 pagineCH03

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2021

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Richard Gareth Thomas come amministratore in data 28 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di William Wolfe Roseff come amministratore in data 28 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Gregory Roy Knight come amministratore in data 28 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Raymond Corbett come amministratore in data 28 mar 2022

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Charles Howard Chisholm come amministratore in data 28 mar 2022

    1 pagineTM01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Dominic Charles Patrick Ford il 09 mar 2022

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2020

    9 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da Warwick House 25 Buckingham Palace Road London SW1W 0PP a Leytonstone House Hanbury Drive Leytonstone London E11 1GA in data 18 gen 2021

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Ciaran O'brien come amministratore in data 31 mar 2020

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Ciaran O'brien come amministratore in data 31 dic 2018

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Anthony David Steele come amministratore in data 31 dic 2018

    1 pagineTM01

    Esercizio contabile precedente prorogato dal 31 ott 2019 al 31 mar 2020

    1 pagineAA01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Charles Howard Chisholm il 30 mar 2020

    2 pagineCH01

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2018

    15 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 31 ott 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione della carica di Michael Patrick O'kane come amministratore in data 24 apr 2017

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 ott 2017

    16 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SOMERFIELD, Jeffrey William
    Park Road
    N8 8JU London
    20 Ramsey Court
    England
    Segretario
    Park Road
    N8 8JU London
    20 Ramsey Court
    England
    201148860001
    FORD, Dominic Charles Patrick
    Bassein Park Road
    W12 9RN London
    25a
    England
    Amministratore
    Bassein Park Road
    W12 9RN London
    25a
    England
    EnglandBritish172825030002
    FAULKNER, Barry James
    68 Saint Nicholas Close
    HP7 9NP Amersham
    Buckinghamshire
    Segretario
    68 Saint Nicholas Close
    HP7 9NP Amersham
    Buckinghamshire
    British63618090001
    MCLENNAN, Graham Craig
    Puttenham Court
    Puttenham
    HP23 4PY Tring
    6
    Hertfordshire
    Segretario
    Puttenham Court
    Puttenham
    HP23 4PY Tring
    6
    Hertfordshire
    British152729370001
    AMES, Richard
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    Amministratore
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    EnglandBritish156827660001
    ASHDOWN, Vaughn Trevor
    Pine Hall
    Crouch Lane Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Pine Hall
    Crouch Lane Borough Green
    TN15 8LU Sevenoaks
    Kent
    British16667900007
    BARTLETT, Warwick Winston
    Apartment 6
    The Point
    IM9 5EG Port St Mary
    Isle Of Man
    Amministratore
    Apartment 6
    The Point
    IM9 5EG Port St Mary
    Isle Of Man
    United KingdomBritish85086550004
    BEAUMONT, Trevor Kenneth
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    Amministratore
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    EnglandBritish109954570001
    BELL, Christopher
    79 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    79 Frenchay Road
    OX2 6TF Oxford
    Oxfordshire
    UkBritish37952640002
    BROWN, John Michael
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    Amministratore
    Milford Court Milford Road
    South Milford
    LS25 5AD Leeds
    British889800001
    CHISHOLM, Charles Howard
    Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    England
    Amministratore
    Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    England
    United KingdomBritish20327800002
    CLARE, Simon John
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    Amministratore
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    EnglandIrish173338740001
    CORBETT, Michael Raymond
    Warwick House
    Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    25
    England
    Amministratore
    Warwick House
    Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    25
    England
    WalesUnited Kingdom193853410004
    CORBETT, Michael Raymond
    10 Goldfinch Drive
    Alsager
    ST7 2GL Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    10 Goldfinch Drive
    Alsager
    ST7 2GL Stoke On Trent
    Staffordshire
    EnglandBritish43792150003
    DONE, Fred
    The Aviary Mill Brow
    Worsley
    M28 2NJ Manchester
    Amministratore
    The Aviary Mill Brow
    Worsley
    M28 2NJ Manchester
    EnglandBritish53299670001
    GOLD, Paul
    16 Conningsby Drive
    WR10 1QX Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    16 Conningsby Drive
    WR10 1QX Pershore
    Worcestershire
    British93026160001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    Amministratore
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    England
    EnglandBritish156821760001
    GOULDEN, Neil Geoffrey
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore
    New Castle House
    Castle Boulevard
    NG7 1FT Nottingham
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish21686380006
    HARDING, David Charles Ian
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    Amministratore
    Greenside House
    50 Station Road Wood Green
    N22 7TP London
    British92569260004
    HARRISON, Dominic Stephen
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    Amministratore
    Queensway
    W2 4QH London
    71
    United KingdomBritish149004500001
    KNIGHT, Gregory Roy
    Esgors
    High Road Thornwood Common
    CM16 6LY Epping
    Essex
    Amministratore
    Esgors
    High Road Thornwood Common
    CM16 6LY Epping
    Essex
    United KingdomBritish108498560001
    NEEDHAM, Charles Robert
    171 Cardinals Walk
    LE5 1LN Leicester
    Leicestershire
    Amministratore
    171 Cardinals Walk
    LE5 1LN Leicester
    Leicestershire
    United KingdomBritish44374760001
    O'BRIEN, Ciaran Thomas Patrick
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    Amministratore
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    EnglandBritish301502830002
    O'KANE, Michael Patrick
    Imperial Drive
    HA2 7JW Harrow
    Imperial House
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Imperial Drive
    HA2 7JW Harrow
    Imperial House
    Middlesex
    England
    EnglandBritish172562130001
    PETTITT, Trevor Dennis
    6 Starrock Road
    CR5 3EH Coulsdon
    Surrey
    Amministratore
    6 Starrock Road
    CR5 3EH Coulsdon
    Surrey
    British85086520001
    ROSEFF, William Wolfe
    Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    England
    Amministratore
    Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    England
    United KingdomBritish8221530006
    SPEARING, Ian John
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    Amministratore
    Greenside House
    50 Station Road, Wood Green
    N22 7TP London
    British34180750003
    STEELE, Anthony David
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    Amministratore
    Greenside House
    50 Station Road
    N22 7TP Wood Green
    United KingdomBritish193930220001
    THOMAS, Richard Gareth
    Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    England
    Amministratore
    Hanbury Drive
    Leytonstone
    E11 1GA London
    Leytonstone House
    England
    United KingdomBritish138178800001
    THORNE, Fiona Talitha Flora
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    Amministratore
    25 Buckingham Palace Road
    SW1W 0PP London
    Warwick House
    EnglandBritish76132170002
    WHITTAKER, John Samuel
    8 Church Road
    Tarleton
    PR4 6UR Preston
    Lancashire
    Amministratore
    8 Church Road
    Tarleton
    PR4 6UR Preston
    Lancashire
    EnglandBritish16740510003
    WOOD, John Dieter
    9 Briggland Court
    Wilsden
    BD15 0HL Bradford
    Amministratore
    9 Briggland Court
    Wilsden
    BD15 0HL Bradford
    United KingdomBritish7186100006

    Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED?

    Dichiarazioni delle persone con controllo significativo
    Notificato ilCessato ilDichiarazione
    31 ott 2016La società sa o ha ragione di credere che non vi siano persone registrabili o entità giuridiche rilevanti registrabili in relazione alla società.

    ASSOCIATION OF BRITISH BOOKMAKERS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Rent deposit deed
    Creato il 07 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit balance being the initial deposit of £27,583.13 and the account see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sackville Property (Gp) Nominee 1 Limited and Sackville Property (Gp) Nominee 2 Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 nov 2003
    Consegnato il 21 nov 2003
    In corso
    Importo garantito
    £25,500 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The sum of £25,500 which relates to a lease granted by the mortgagee to the mortgagor in respect of part second floor regency house 1-4 warwick street london W1.
    Persone aventi diritto
    • Alfred Lichter and Joseph Scwartz
    Transazioni
    • 21 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0