KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàKIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04569223
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Estate Office
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    Bedfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STEELRAY NO. 194 LIMITED22 ott 200222 ott 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2022

    Quali sono le ultime deposizioni per KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Cessazione della carica di Paul Simon Fernback come amministratore in data 31 dic 2023

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan Geoffrey Fernback come amministratore in data 31 dic 2023

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2023 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2022

    11 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 8 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 10 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 045692230011 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2021

    11 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2021 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2020

    12 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 9 in pieno

    2 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2020 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 set 2019

    12 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Iscrizione dell'ipoteca 045692230011, creata il 25 feb 2019

    5 pagineMR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2018

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 mag 2017 con aggiornamenti

    6 pagineCS01

    Bilancio abbreviato redatto al 30 set 2016, revisionato

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Toni Brook come segretario in data 24 ott 2016

    1 pagineTM02

    Chi sono gli amministratori di KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HUNT, Sharon Anne
    Oakley House
    Oakley House
    MK43 7ST Bedford
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    Segretario
    Oakley House
    Oakley House
    MK43 7ST Bedford
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    217622840001
    LOUSADA, Simon Charles
    Oakley
    MK43 7ST Bedford
    Oakley House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Oakley
    MK43 7ST Bedford
    Oakley House
    Bedfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish16199140003
    BROOK, Toni
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    Segretario
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    Estate Office
    Bedfordshire
    England
    174438760001
    LOUSADA, Charles Terence
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    Segretario
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    British94444470001
    STEELRAY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Richmond Point
    Dorset
    Segretario
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Richmond Point
    Dorset
    60731070001
    FERNBACK, Alan Geoffrey
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    Amministratore
    20 Park Avenue
    Farnborough Park
    BR6 8LL Orpington
    The Tudors
    Kent
    EnglandBritish38497170001
    FERNBACK, Paul Simon
    20 Park Avenue
    Farnborough
    BR6 8LL Orpington
    Kent
    Amministratore
    20 Park Avenue
    Farnborough
    BR6 8LL Orpington
    Kent
    United KingdomBritish58655410001
    LOUSADA, Charles Terence
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    Amministratore
    Estate Office Crawley Park
    MK42 0UU Husborne Crawley
    Bedford
    EnglandBritish94444470001
    TYRRELL, Brinley George
    Coton House
    Clay Coton
    NN6 6JU Northampton
    Northamptonshire
    Amministratore
    Coton House
    Clay Coton
    NN6 6JU Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish141886210001
    STEELE NOMINEES LTD
    Richmond Point
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Dorset
    Amministratore
    Richmond Point
    43 Richmond Hill
    BH2 6LR Bournemouth
    Dorset
    103417250001

    Chi sono le persone con controllo significativo di KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Euroway Homes Limited
    W1S 1DE London
    70-71 New Bond Street
    London
    United Kingdom
    03 mag 2016
    W1S 1DE London
    70-71 New Bond Street
    London
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLtd
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazione70-71 New Bond Street, London
    Numero di registrazione02265680
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.
    Lousada Investments Limited
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    The Estate Office
    Bedfordshire
    England
    03 mag 2016
    Oakley House
    MK43 7ST Oakley
    The Estate Office
    Bedfordshire
    England
    No
    Forma giuridicaLimited
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleEngland & Wales
    Luogo di registrazioneEstate Office, Oakley House, Oakley, Beds, Uk
    Numero di registrazione09221425
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 25% ma non più del 50% delle azioni della società.

    KIDDERMINSTER PROPERTY INVESTMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 25 feb 2019
    Consegnato il 06 mar 2019
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 06 mar 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land on the north and east sides of clensmore street kidderminster t/nos HW96027 WR48934 and WR47900. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings and the south east side of churchfields kidderminster t/n WR83405. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 giu 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 06 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The unicorn inn broad street kidderminster t/n WR88487. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 nov 2022Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Legal charge
    Creato il 25 giu 2004
    Consegnato il 08 lug 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Legal mortgage over property known as units 23-26 churchfields business park clensmore street kidderminster worcestershire DY10 2JS with title number HW96027. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 lug 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 23 apr 2004
    Consegnato il 07 mag 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property known as the unicorn inn broad street kidderminster. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 07 mag 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 21 nov 2003
    Consegnato il 28 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Churchfields kidderminster worcestershire t/n's WR72007, HW120256, HW200809 and WR52572. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 20 nov 2003
    Consegnato il 04 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    £1,075,000 due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    F/H land at churchfields, kidderminster, wyre forest, worcestershire t/no WR72007 and HW120256 and HW200809 and WR53572.
    Persone aventi diritto
    • Cms (Kidderminster) Limited
    Transazioni
    • 04 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 01 mag 2003
    Consegnato il 08 mag 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land and buildings on the east side of clensmore street, kidderminster t/n's WR47900 and WR48934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 08 mag 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 2003
    Consegnato il 15 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The property shown for the purposes of identification only edged red on plan 1 attached to the transfer dated 10TH march 2003 between the company and tomkinsons carpets limited. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 10 mar 2003
    Consegnato il 15 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    All land and buildings on the east side of clensmore street kidderminster with title numbers WR57900 and WR48934. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 15 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 feb 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0