AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED

AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04571657
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    28 Derby Street
    L39 2BY Ormskirk
    Lancashire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DUO BUILD LIMITED24 ott 200224 ott 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital28 ott 2014

    Stato del capitale al 28 ott 2014

    • Capitale: GBP 120
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2013

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital24 ott 2013

    Stato del capitale al 24 ott 2013

    • Capitale: GBP 120
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2012

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Cessazione della carica di Clive Greenwood come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2011

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2010

    7 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    13 pagineAA

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2008

    9 pagineAA

    Cessazione della carica di Clive Greenwood come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 24 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Clive Norman Kristian Greenwood il 24 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Calvin Greig Wigney il 24 ott 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    1 pagine225

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed duo build LIMITED\certificate issued on 18/02/09
    2 pagineCERTNM

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    4 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    1 pagine288b

    legacy

    2 pagine288a

    Chi sono gli amministratori di AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Lionel Edwin
    6 West Croft
    Much Hoole
    PR4 4QP Preston
    Lancs
    Segretario
    6 West Croft
    Much Hoole
    PR4 4QP Preston
    Lancs
    British113755350001
    WIGNEY, Calvin Greig
    3 Dart Close
    Alsager
    ST7 2HY Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    3 Dart Close
    Alsager
    ST7 2HY Stoke On Trent
    Staffordshire
    United KingdomAustralian35621480001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Segretario
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    British2582690002
    LASSO, Francisco Xavier
    10 Wavering Down Rise
    Shute Shelf
    BS26 2JJ Axbridge
    Somerset
    Segretario
    10 Wavering Down Rise
    Shute Shelf
    BS26 2JJ Axbridge
    Somerset
    British85474220002
    PENMAN, Ceilidh
    11 Foxcote Road
    Ashton
    BS3 2DA Bristol
    Segretario
    11 Foxcote Road
    Ashton
    BS3 2DA Bristol
    British85165100001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    GRAFTON, Roger Clive
    2 Temple Street
    Keynsham
    BS31 1EG Bristol
    Amministratore
    2 Temple Street
    Keynsham
    BS31 1EG Bristol
    EnglandBritish109697890001
    GREENWOOD, Clive Norman Kristian
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    Amministratore
    Meadows Farm
    SK12 7EH Kettleshulme
    Cheshire
    United KingdomBritish2582690002
    LALLY, Martin Christopher
    74 Gloucester Road
    Almondsbury
    BS32 4HQ Bristol
    Amministratore
    74 Gloucester Road
    Almondsbury
    BS32 4HQ Bristol
    United KingdomBritish37063970002
    LASSO, Francisco Xavier
    10 Wavering Down Rise
    Shute Shelf
    BS26 2JJ Axbridge
    Somerset
    Amministratore
    10 Wavering Down Rise
    Shute Shelf
    BS26 2JJ Axbridge
    Somerset
    United KingdomBritish85474220002

    AMALGAMATED PROPERTY INVESTMENTS (SOUTH WEST) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 21 nov 2008
    Consegnato il 27 nov 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land lying to the east of kenn road, clevedon by way of fixed charge, the benefit of all covenants & rights concerning the property & all plant machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 nov 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal mortgage
    Creato il 18 dic 2003
    Consegnato il 30 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H property k/a 520 business park, clevedon, north somerset t/no ST200850. By way of specific charge the goodwill and connection of the business or businesses and also by way of floating security all moveable plant machinery implements furniture equipment stock-in-trade work in progress and other chattels.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 30 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 25 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 14 nov 2003
    Consegnato il 15 nov 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) P.L.C.
    Transazioni
    • 15 nov 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 07 gen 2003
    Consegnato il 15 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 17 lug 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 03 gen 2003
    Consegnato il 11 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    F/H land lying to the east of kenn road clevedon t/n ST200850. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 11 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 24 feb 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0