CASTLEGATE 795 LIMITED

CASTLEGATE 795 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCASTLEGATE 795 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04575239
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CASTLEGATE 795 LIMITED?

    • Attività di altre società holding n.c.a. (64209) / Attività finanziarie e assicurative

    Dove si trova CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    4th Floor 24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    INDEPENDENT INSPECTIONS HOLDINGS LIMITED23 mag 200623 mag 2006
    SRW HOLDINGS LIMITED06 gen 200406 gen 2004
    JOKASTDA LIMITED28 ott 200228 ott 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 apr 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Modifica dei dettagli di Independent Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 06 gen 2023

    2 paginePSC05

    Nomina di Cossey Cosec Services Limited come segretario in data 25 gen 2023

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Rjp Secretaries Limited come segretario in data 25 gen 2023

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ott 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL United Kingdom a 4th Floor 24 Old Bond Street Mayfair London W1S 4AW in data 06 gen 2023

    1 pagineAD01

    Dettagli del direttore cambiati per Gold Round Limited il 25 lug 2022

    1 pagineCH02

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 25 lug 2022

    2 paginePSC05

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2021

    7 pagineAA

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed independent inspections holdings LIMITED\certificate issued on 22/04/22
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name22 apr 2022

    Cambio di nome" per delibera

    NM01
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 19 apr 2022

    RES15

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ott 2021 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 21 lug 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2020

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Alan Albert Horton come amministratore in data 30 giu 2020

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ott 2020 con aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Gold Round Limited come persona con controllo significativo il 18 apr 2016

    2 paginePSC05

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Stuart Pace il 29 giu 2020

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 30 apr 2019

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 28 ott 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 a C Court High Street Thames Ditton Surrey KT7 0SR England a Ground Floor, Egerton House 68 Baker Street Weybridge Surrey KT13 8AL in data 12 ago 2019

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Independent Group (Uk) Limited come persona con controllo significativo il 09 ago 2019

    2 paginePSC05

    Dettagli del segretario cambiati per Rjp Secretaries Limited il 09 ago 2019

    1 pagineCH04

    Tutta la proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 6

    2 pagineMR05

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    1 pagineMR04

    Chi sono gli amministratori di CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COSSEY COSEC SERVICES LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Segretario
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione14344691
    302964180001
    PACE, Stuart
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    EnglandBritish207506130003
    GOLD ROUND LIMITED
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Amministratore
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione05687325
    149588400001
    DICKINSON, Louise
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Segretario
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    British139480580001
    POLLARD, Niall Mackinlay
    57 Royton Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HJ Preston
    Lancashire
    Segretario
    57 Royton Drive
    Whittle Le Woods
    PR6 7HJ Preston
    Lancashire
    British176786520001
    WEST, Deborah
    3 Lavender Close
    Fulwood
    PR2 9RA Preston
    Lancashire
    Segretario
    3 Lavender Close
    Fulwood
    PR2 9RA Preston
    Lancashire
    British91741940001
    WILLS, Stephen Robert
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Segretario
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    British35049690003
    RJP SECRETARIES LIMITED
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Segretario
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione02989995
    61999120002
    BARRETT, John
    3 Rockfield Close
    TQ14 8TS Teignmouth
    Devon
    Amministratore
    3 Rockfield Close
    TQ14 8TS Teignmouth
    Devon
    United KingdomBritish118475070001
    DICKINSON, Louise
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish139480580001
    HORTON, Alan Albert
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    Amministratore
    68 Baker Street
    KT13 8AL Weybridge
    Ground Floor, Egerton House
    Surrey
    United Kingdom
    EnglandBritish182208240001
    LEE, Peter Francis
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish207608120001
    LEES, Stuart
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish70032700001
    LLOYD JONES, Andrew Mark
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish180809810001
    MAHONEY, Kevin David
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    Amministratore
    6 Ferrymans Quay
    William Morris Way
    SW6 2UT London
    United KingdomBritish63238350002
    MAUDE, Simon David
    Bowser
    Old Mount Road
    HD7 6NN Marsden
    West Yorkshire
    Amministratore
    Bowser
    Old Mount Road
    HD7 6NN Marsden
    West Yorkshire
    United KingdomBritish89719660002
    MCINNES, Timothy Ian
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    34 Cumberland Drive
    Bowdon
    WA14 3QP Altrincham
    Cheshire
    United KingdomBritish108973030002
    POLLARD, Niall Mackinlay
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    Amministratore
    6 Fulwood Park
    Caxton Road, Fulwood
    PR2 9NZ Preston
    Lancashire
    EnglandBritish176786520001
    SMITH, Andrew John
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    Amministratore
    High Street
    KT7 0SR Thames Ditton
    2 A C Court
    Surrey
    England
    United KingdomBritish207506140001
    VINCENT, Michael
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    Amministratore
    23 Saint Aubyns's Avenue
    SW19 7BL London
    EnglandBritish99258270001
    WATKINS, Steven James
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Crescent
    TR11 2DL Falmouth
    1
    Cornwall
    United Kingdom
    United KingdomBritish127928260002
    WILLS, Kathleen Jean
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Lancashire
    Amministratore
    5 The Orchard
    Little Eccleston
    PR3 0YX Preston
    Lancashire
    British61097710002
    WILLS, Stephen Robert
    Whitelodge 141 Hardhorn Road
    FY6 8ES Poulton Le Fylde
    Lancashire
    Amministratore
    Whitelodge 141 Hardhorn Road
    FY6 8ES Poulton Le Fylde
    Lancashire
    United KingdomBritish35049690004

    Chi sono le persone con controllo significativo di CASTLEGATE 795 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    18 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleUnited Kingdom
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05687325
    Natura del controllo
    • La persona ha il diritto di esercitare, o esercita effettivamente, un'influenza significativa o un controllo sulla società.
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    06 apr 2016
    24 Old Bond Street
    Mayfair
    W1S 4AW London
    4th Floor
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaLimited By Shares
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione06732498
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    CASTLEGATE 795 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 01 set 2016
    Consegnato il 13 set 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Blackstar 2016 Limited
    Transazioni
    • 13 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 03 giu 2016
    Consegnato il 16 giu 2016
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Secure Trust Bank PLC
    Transazioni
    • 16 giu 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A composite guarantee and debenture
    Creato il 31 gen 2011
    Consegnato il 08 feb 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Lloyd-Jones
    Transazioni
    • 08 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 28 mar 2019Tutta la proprietà o l'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 28 mar 2019Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 02 lug 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited(Investor)
    Transazioni
    • 02 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mag 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 26 giu 2009
    Consegnato il 30 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transazioni
    • 30 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Accession deed
    Creato il 18 lug 2006
    Consegnato il 20 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Allied Irish Bank PLC in Its Capacity as Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Trustee)
    Transazioni
    • 20 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 lug 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 19 feb 2004
    Consegnato il 27 feb 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 18 dic 2002
    Consegnato il 03 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    38,44 and 46 avenham st,preston,lancs; t/no la 183448. by way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 03 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0