AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED

AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAGORA SHOPPING CENTRES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04582001
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Hill House
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TINKERFROST LIMITED05 nov 200205 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa

    1 pagineSOAS(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 03 ott 2017

    3 pagine3.6

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    legacy

    pagineLQ01

    Notifica di cessazione dell'attività di curatore o gestore

    4 pagineRM02

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 gen 2017

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 gen 2016

    3 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 gen 2015

    3 pagine3.6

    Relazione del commissario giudiziario amministrativo

    18 pagine3.10

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 10 gen 2014

    3 pagine3.6

    Indirizzo della sede legale modificato da * 24 Bruton Place London W1J 6NE* in data 30 gen 2013

    2 pagineAD01

    legacy

    3 pagineLQ01

    Cessazione della carica di Neil Burnett come amministratore

    2 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    15 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2013

    Stato del capitale al 16 gen 2013

    • Capitale: GBP 14,646,026
    SH01

    Cessazione della carica di Robert Corry come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Heather Curtis come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Lanchester come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Robert Game come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Mark Keogh come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Philip Warner come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Nations House 103 Wigmore Street London W1U 1AE* in data 28 ago 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di David Edward Brown come amministratore

    3 pagineAP01

    Chi sono gli amministratori di AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CURTIS, Heather
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    Segretario
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    British171899400001
    BROWN, David Edward
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    Amministratore
    1 Little New Street
    EC4A 3TR London
    Hill House
    United KingdomBritish78731890002
    CORRY, Robert John
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    Segretario
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    British171582190001
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Segretario
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    British7014460002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BELL, Simon Harold
    Ravelston Dykes
    EH4 3JE Edinburgh
    17
    Amministratore
    Ravelston Dykes
    EH4 3JE Edinburgh
    17
    British128941230001
    BOTHWELL, Karen Margaret
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    68 Ravelston Dykes
    EH12 6HF Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish34800860003
    BRADLEY, Pauline Anne
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    Amministratore
    Spruce Tree House
    By Gleneagles
    PH4 1RG Auchterarder
    Perthshire
    British122926460001
    BURNETT, Neil Scott
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    Amministratore
    Hermitage Gardens
    EH10 6DL Edinburgh
    1
    Scotland
    United Kingdom
    ScotlandBritish93937250003
    BURNETT, Neil Scott
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    Amministratore
    5 Cluny Avenue
    EH10 4RN Edinburgh
    British93937250001
    COLLINS, Peter William
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    The Oaks
    23 Croft Road
    RG40 3HX Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritish26086560001
    DICKSON, Pamela Simone
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    Amministratore
    38 Belmont Gardens
    EH12 6JD Edinburgh
    United KingdomScottish91810830001
    EDWARDS, David Lindsey
    4 Rosebury Drive
    Bisley
    GU24 9RX Woking
    Surrey
    Amministratore
    4 Rosebury Drive
    Bisley
    GU24 9RX Woking
    Surrey
    British53245050002
    GAME, Robert William
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    Amministratore
    Newbury Lane
    Cousley Wood
    TN5 6HD Wadhurst
    Rosemary Cottage
    East Sussex
    United KingdomEnglish139555050001
    HEPBURN, Alastair John Harley
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish114477450001
    HEWITT, Alistair James Neil
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    Amministratore
    12 Annickbank
    Stewarton
    KA3 5QT Kilmarnock
    Ayrshire
    ScotlandBritish113081830001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Amministratore
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    KEOGH, Mark William
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    Amministratore
    Norfolk House 28 Kidmore Road
    Caversham
    RG4 7LU Reading
    EnglandIrish62140690001
    LANCHESTER, David James
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    Amministratore
    1 Holly Close
    IG9 6HT Buckhurst Hill
    Essex
    United KingdomBritish7014460002
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MACDONALD, Gary
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    Amministratore
    23 Hillview Drive
    EH12 8QP Edinburgh
    Midlothian
    British127023890001
    MOORE, Richard
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    88 Alzey Gardens
    AL5 5SZ Harpenden
    Hertfordshire
    British73793650001
    MUNRO, Robert Alexander
    Plumley House,122 Bradbourne Road
    TN13 3QP Sevenoaks
    Kent
    Amministratore
    Plumley House,122 Bradbourne Road
    TN13 3QP Sevenoaks
    Kent
    British74429120001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SMALLWOOD, James Douglas Mortimer
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    Amministratore
    4 Chestnuts
    SG13 8AQ Hertford
    Hertfordshire
    EnglandBritish110517930001
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    STEVENS, Michael John
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    Amministratore
    32 Woodfield Park
    HP6 5QH Amersham
    Buckinghamshire
    United KingdomBritish60348780002
    STRACHAN, Philip David
    68 St John's Road
    BR5 1HY Orpington
    Kent
    Amministratore
    68 St John's Road
    BR5 1HY Orpington
    Kent
    British96666000001
    TAYLOR, David Hunter
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    Amministratore
    Primrose Villa
    19 Glenbrook
    EH14 7JE Balerno
    Midlothian
    British70908350001
    VAGHELA, Vinod Bachulal
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    Amministratore
    99 Cathles Road
    Balham
    SW12 9LF London
    EnglandBritish5689250001
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    Amministratore
    Bruton Place
    W1J 6NE London
    24
    United KingdomBritish7356840002
    WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    Amministratore
    Marden Grange
    Marden
    SN10 3RQ Devizes
    Wiltshire
    United KingdomBritish7356840001

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2008
    Consegnato il 18 feb 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H market place shopping centre bolton t/no GM485110,f/h 38 and 40 market street,16A,18,20,22,24 and 26 corporation street and 1 lorne street bolton t/no GM36285,f/h 28 and 30 corporation street bolton t/no's GM99081 and GM14797 (for details of further properties charged please refer to form 395) fixed charge all buildings and other structures,any goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Truste for Itself and Each of the Finance Parties
    Transazioni
    • 18 feb 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 23 mar 2007
    Consegnato il 12 apr 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any a finance party or any b finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The properties being f/h cavern walks, liverpoole, marina walk being land on the south side of mathew street liverpool t/n MS422649. F/h and l/h fishergate preston t/nos LA724316, LA728630, LA774760 and LA612623. (For details of further pro. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Trustee)
    Transazioni
    • 12 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security interest
    Creato il 05 mar 2003
    Consegnato il 18 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All rights title and interest in and to the shares all dividends interest and other income in respect of the said shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and Each of the a Financeparties and Each of the B Finance Parties
    Transazioni
    • 18 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 12 dic 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 05 mar 2003
    Consegnato il 13 mar 2003
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any a finance party or any b finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 13 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 117 gen 2013Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 104 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
    • 104 ott 2017Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (RM02)
      • Numero di pratica 1

    AGORA SHOPPING CENTRES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore amministrativo nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Neville Barry Kahn
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ricevitore amministrativo
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Philip Stephen Bowers
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London
    Ricevitore amministrativo
    Po Box 810, 66 Shoe Lane
    EC4A 3WA London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0