TLLC LEVPROPCO7 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TLLC LEVPROPCO7 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04582106 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| BOXCLOSE LIMITED | 05 nov 2002 | 05 nov 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2013 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 045821060004, creata il 29 nov 2013 | 148 pagine | MR01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Grant David Hearn come amministratore in data 25 nov 2013 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Nomina di Mr Peter Darren Gowers come amministratore in data 25 nov 2013 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 4 pagine | AA | ||||||||||||||
Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore in data 19 mar 2013 | 3 pagine | AP01 | ||||||||||||||
Nomina di Joanna Boydell come segretario in data 19 mar 2013 | 3 pagine | AP03 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 28 mar 2013 | 2 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Jon William Mortimore come segretario in data 28 mar 2013 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 3 pagine | AA | ||||||||||||||
legacy | 16 pagine | MG01 | ||||||||||||||
Cessazione della carica di Guy Paul Cuthbert Parsons come amministratore in data 20 apr 2012 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010 | 12 pagine | AA | ||||||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2009 | 15 pagine | AA | ||||||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 16 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Guy Paul Cuthbert Parsons il 03 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Paul Victor Harvey il 03 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Grant David Hearn il 03 feb 2010 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||||||
Chi sono gli amministratori di TLLC LEVPROPCO7 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYDELL, Joanna | Segretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | British | 164373820001 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| BOYDELL, Joanna | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164373820001 | |||||
| GOWERS, Peter Darren | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | England | British | 157443090002 | |||||
| HARVEY, Paul Victor | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 116809270002 | |||||
| HICKS, Christopher Michael | Segretario | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Segretario | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | British | 141586330001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Segretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | 93906210001 | ||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| TRAVELREST SERVICES LIMITED | Segretario | Parklands Court 24 Parklands Birmingham Great Park Rubery B45 9PZ Birmingham West Midlands | 42204690005 | |||||||
| HEARN, Grant David | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | 88628480002 | |||||
| HICKS, Christopher Michael | Amministratore | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| JACKSON, Kevin David | Amministratore | Field House 147 Main Street Sutton Bonington LE12 5PE Loughborough | England | British | 141586330001 | |||||
| LAYTON, Matthew Robert | Amministratore delegato nominato | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 93906210001 | |||||
| PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 102187770002 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| TURL, Simon Charles | Amministratore | Arden House Eastwell Road LE14 4SS Scalford Leicestershire | British | 80261230001 | ||||||
| TURNER, Harry | Amministratore | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | 166789700001 |
TLLC LEVPROPCO7 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 29 nov 2013 Consegnato il 05 dic 2013 | In corso | ||
Breve descrizione Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental debenture | Creato il 25 ott 2012 Consegnato il 31 ott 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 26 set 2006 Consegnato il 04 ott 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 04 feb 2003 Consegnato il 12 feb 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All that property situated at kendrick street, warrington. All that property situated at 1 midpoint, dick lane, pudsey, bradford. All that property situated at riverside, nottingham. For further details of all property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0