TLLC HOLDINGS3 LIMITED

TLLC HOLDINGS3 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTLLC HOLDINGS3 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04588791
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TLLC HOLDINGS3 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Sleepy Hollow
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Oxfordshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    STICKGROVE LIMITED13 nov 200213 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per TLLC HOLDINGS3 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Indirizzo della sede legale modificato da 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a Sleepy Hollow Aylesbury Road Thame Oxfordshire OX9 3AT in data 08 feb 2019

    2 pagineAD01

    Cessazione della carica di a G Secretarial Limited come segretario in data 11 gen 2016

    2 pagineTM02

    Ripristino per ordine del tribunale

    3 pagineAC92

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital01 dic 2014

    Stato del capitale al 01 dic 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 045887910004

    148 pagineMR01

    Nomina di Mr Peter Darren Gowers come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Grant Hearn come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2013

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    12 pagineAA

    Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Joanna Boydell come segretario

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jon Mortimore come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jon Mortimore come segretario

    2 pagineTM02

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    16 pagineMG01

    Cessazione della carica di Guy Parsons come amministratore

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    British164373820001
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164373820001
    GOWERS, Peter Darren
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish157443090002
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish116809270002
    GARLAND, Michael Charles
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Segretario
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Uk174553070001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Segretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Segretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    British93906210001
    SELLARS, Ian
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    Segretario
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    British107731430001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    GARLAND, Michael Charles
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    Amministratore
    21 Lichfield Road
    Kew Gardens
    TW9 3JR Richmond
    Surrey
    United KingdomUk174553070001
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish88628480002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish93906210001
    PARKER, Carl Henry
    82 Alleyn Road
    Dulwich
    SE21 8AH London
    Amministratore
    82 Alleyn Road
    Dulwich
    SE21 8AH London
    United KingdomBritish53480410003
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    SCOBLE, Timothy James
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    57 Old Road
    Wheatley
    OX33 1NX Oxford
    Oxfordshire
    United KingdomBritish83743120001
    SELLARS, Ian
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    Amministratore
    1 Ranelagh Avenue
    SW6 3PJ London
    United KingdomBritish107731430001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    TLLC HOLDINGS3 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2013
    Consegnato il 05 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Aberdeen airport, burnside drive, off riverview drive, dyce, aberdeen, aberdeenshire t/no ABN84416. Aberdeen bucksburn, A96 inverurie road, bucksburn, aberdeen, abderdeenshire t/no ABN79397. Aberdeen central justice mill lane, justice mill lane, aberdeen t/no ABN107231. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A supplemental debenture
    Creato il 25 ott 2012
    Consegnato il 31 ott 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security accession deed
    Creato il 26 set 2006
    Consegnato il 04 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 04 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 18 dic 2002
    Consegnato il 31 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including (I) property at navan rd, dublin comprised in folio 113016F of the register county dublin except that part thereof marked "HY7U"; (ii) property at cork rd, waterford, folio 18739F, county waterford; (iii) part of the lands of miltonsfields in the barony of nethercross, county of dublin, folio no 90295F; (see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, London, as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transazioni
    • 31 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0