TLLC HOLDINGS3 LIMITED
Panoramica
| Nome della società | TLLC HOLDINGS3 LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04588791 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?
- Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche
Dove si trova TLLC HOLDINGS3 LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Sleepy Hollow Aylesbury Road OX9 3AT Thame Oxfordshire |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| STICKGROVE LIMITED | 13 nov 2002 | 13 nov 2002 |
Quali sono gli ultimi bilanci di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2014 |
Quali sono le ultime deposizioni per TLLC HOLDINGS3 LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 100 Barbirolli Square Manchester M2 3AB a Sleepy Hollow Aylesbury Road Thame Oxfordshire OX9 3AT in data 08 feb 2019 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Cessazione della carica di a G Secretarial Limited come segretario in data 11 gen 2016 | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Ripristino per ordine del tribunale | 3 pagine | AC92 | ||||||||||
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2014 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Iscrizione dell'ipoteca 045887910004 | 148 pagine | MR01 | ||||||||||
Nomina di Mr Peter Darren Gowers come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Grant Hearn come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2012 | 12 pagine | AA | ||||||||||
Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Joanna Boydell come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon Mortimore come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Jon Mortimore come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2011 | 14 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti | 6 pagine | AR01 | ||||||||||
legacy | 16 pagine | MG01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Guy Parsons come amministratore | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di TLLC HOLDINGS3 LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYDELL, Joanna | Segretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | British | 164373820001 | ||||||
| BOYDELL, Joanna | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 164373820001 | |||||
| GOWERS, Peter Darren | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxfordshire United Kingdom | England | British | 157443090002 | |||||
| HARVEY, Paul Victor | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 116809270002 | |||||
| GARLAND, Michael Charles | Segretario | 21 Lichfield Road Kew Gardens TW9 3JR Richmond Surrey | Uk | 174553070001 | ||||||
| HICKS, Christopher Michael | Segretario | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Segretario | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | British | 93906210001 | ||||||
| SELLARS, Ian | Segretario | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | British | 107731430001 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Segretario | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Segretario nominato | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
| GARLAND, Michael Charles | Amministratore | 21 Lichfield Road Kew Gardens TW9 3JR Richmond Surrey | United Kingdom | Uk | 174553070001 | |||||
| HEARN, Grant David | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | England | British | 88628480002 | |||||
| HICKS, Christopher Michael | Amministratore | Valpy Cottage 3 St Andrews Road RG4 7PH Reading Berkshire | British | 53932930001 | ||||||
| LAYTON, Matthew Robert | Amministratore delegato nominato | Flat 49 8 New Crane Wharf New Crane Place E1W 3TX London | British | 900019870001 | ||||||
| MORTIMORE, Jon William | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 93906210001 | |||||
| PARKER, Carl Henry | Amministratore | 82 Alleyn Road Dulwich SE21 8AH London | United Kingdom | British | 53480410003 | |||||
| PARSONS, Guy Paul Cuthbert | Amministratore | Aylesbury Road OX9 3AT Thame Sleepy Hollow Oxon United Kingdom | United Kingdom | British | 102187770002 | |||||
| RICHARDS, Martin Edgar | Amministratore delegato nominato | 89 Thurleigh Road SW12 8TY London | British | 900002870001 | ||||||
| SCOBLE, Timothy James | Amministratore | 57 Old Road Wheatley OX33 1NX Oxford Oxfordshire | United Kingdom | British | 83743120001 | |||||
| SELLARS, Ian | Amministratore | 1 Ranelagh Avenue SW6 3PJ London | United Kingdom | British | 107731430001 | |||||
| TURNER, Harry | Amministratore | Shepherds Cottage The Vale Golf & Country Club Bishampton Fields WR10 2LZ Bishampton Near Pershore Worcestershire | England | British | 166789700001 |
TLLC HOLDINGS3 LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Creato il 29 nov 2013 Consegnato il 05 dic 2013 | In corso | ||
Breve descrizione Aberdeen airport, burnside drive, off riverview drive, dyce, aberdeen, aberdeenshire t/no ABN84416. Aberdeen bucksburn, A96 inverurie road, bucksburn, aberdeen, abderdeenshire t/no ABN79397. Aberdeen central justice mill lane, justice mill lane, aberdeen t/no ABN107231. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge. Contiene un'ipoteca flottante: Sì Contiene un'ipoteca fissa: Sì | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| A supplemental debenture | Creato il 25 ott 2012 Consegnato il 31 ott 2012 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Security accession deed | Creato il 26 set 2006 Consegnato il 04 ott 2006 | In corso | Importo garantito All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 18 dic 2002 Consegnato il 31 dic 2002 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All money or liabilities due or to become due from any chargor or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Including (I) property at navan rd, dublin comprised in folio 113016F of the register county dublin except that part thereof marked "HY7U"; (ii) property at cork rd, waterford, folio 18739F, county waterford; (iii) part of the lands of miltonsfields in the barony of nethercross, county of dublin, folio no 90295F; (see form 395 for details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0