TLLC CMPROPCO1 LIMITED

TLLC CMPROPCO1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTLLC CMPROPCO1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04588947
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TLLC CMPROPCO1 LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TLLC CMPROPCO1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Berkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TLLC CMPROPCO1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    VIOLETDEW LIMITED13 nov 200213 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TLLC CMPROPCO1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per TLLC CMPROPCO1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    27 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 dic 2015

    49 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a Kpmg Llp Arlington Business Park Theale Reading Berkshire RG7 4SD in data 24 dic 2014

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    RESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 10 dic 2014

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 nov 2014

    Stato del capitale al 12 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital30 ott 2013

    Stato del capitale al 30 ott 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    10 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    3 pagineAR01

    legacy

    20 pagineMG01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    3 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2008

    12 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di TLLC CMPROPCO1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Segretario
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    AustralianChartered Accountant57113450003
    GUMM, Sandra Louise
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Amministratore
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    EnglandAustralianChartered Accountant57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    Amministratore
    Arlington Business Park
    Theale
    RG7 4SD Reading
    Kpmg Llp
    Berkshire
    United KingdomBritishChartered Surveyor6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Segretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Segretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    BritishProperty Director141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Segretario
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    BritishCompany Director93906210001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Amministratore
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Amministratore
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritishProperty Director141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Amministratore
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritishCompany Director93906210001
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Amministratore
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    BritishDirector80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001

    TLLC CMPROPCO1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Confirmatory security agreement
    Creato il 28 gen 2010
    Consegnato il 04 feb 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transazioni
    • 04 feb 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security deed
    Creato il 19 ott 2004
    Consegnato il 27 ott 2004
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each company to any finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All f/h and l/h property, all buildings erections fixtures fittings (including trade fixtures and fittings) fixed plant and machinery, investments, plant and machinery, credit balances, book debts, insurances, contracts, intercompany loans, goodwill & uncalled capital floating charge all assets not charged or assigned under the deed, all assets located in scotland. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for the Finance Parties(Security Agent)
    Transazioni
    • 27 ott 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 27 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subjects at 9 bridge street and 165 union street,aberdeen; t/no abn 18435.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 14 february 2003 and
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 27 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities due or to become due from the company or by any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The subjects at 9 bridge street and 165 union street,aberdeen; t/no abn 18435.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 18 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including lands at kendrick st,warrington,CH436481;1 midpoint,dick lane,pudsey,bradford,WYK678625;riverside,nottingham,NT328755. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transazioni
    • 18 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 12 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transazioni
    • 12 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 nov 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TLLC CMPROPCO1 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    10 dic 2014Inizio della liquidazione
    30 dic 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Neil David Gostelow
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London
    Praticante
    8 Salisbury Square
    EC4Y 8BB London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0