TER 300 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTER 300 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04589136
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TER 300 LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova TER 300 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Victoria Works
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Nottinghamshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TER 300 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ICON POLYMER HOLDINGS LIMITED15 gen 200315 gen 2003
    WEAVEDEGREE LIMITED13 nov 200213 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TER 300 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 set 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per TER 300 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed icon polymer holdings LIMITED\certificate issued on 23/02/12
    2 pagineCERTNM
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 13 feb 2012

    RES15

    Avviso di cambio di nome"

    2 pagineCONNOT

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital21 nov 2011

    Stato del capitale al 21 nov 2011

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Denzil Pryce il 24 ago 2011

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 30 set 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio redatto al 30 set 2009

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 31 ott 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy Denzil Pryce il 11 nov 2009

    2 pagineCH01

    legacy

    2 pagine288a

    legacy

    1 pagine288b

    Bilancio redatto al 30 set 2008

    1 pagineAA

    legacy

    3 pagine363a

    legacy

    1 pagine353

    legacy

    1 pagine287

    legacy

    1 pagine190

    legacy

    1 pagine288c

    Bilancio redatto al 30 set 2007

    1 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    Bilancio redatto al 30 set 2006

    1 pagineAA

    legacy

    2 pagine363a

    legacy

    1 pagine288b

    Chi sono gli amministratori di TER 300 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Segretario
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    British112482850001
    FINN, Shaun Raymond
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    Amministratore
    11 Nottingham Road
    Lowdham
    NG14 7AL Nottingham
    EnglandBritish112482850001
    PRYCE, Timothy Denzil
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    Amministratore
    Thrumpton Lane
    DN22 6HH Retford
    Victoria Works
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish139882140005
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Segretario
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    British104260670001
    JOHNSON, Joanne Elizabeth
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    Segretario
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    British86411760001
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Segretario
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    British44240520002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BAILEY, Roger Piers Marden
    Cheriton
    Pikes Hill Avenue
    SO43 7AX Lyndhurst
    Hampshire
    Amministratore
    Cheriton
    Pikes Hill Avenue
    SO43 7AX Lyndhurst
    Hampshire
    British104169400001
    CALLAN, Maurice Simon
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Ayres Cottage
    71 Bicester Road Long Crendon
    HP18 9EE Aylesbury
    Buckinghamshire
    British72172980001
    GOGERTY, Richard Howard
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    Amministratore
    Marriner Crescent
    LN2 1BB Lincoln
    2
    Lincolnshire
    EnglandBritish83926860003
    HARRIS, Mark Smeeth
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    Amministratore
    21 Oakdene
    Sunningdale
    SL5 0BU Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritish104260670001
    JOHNSON, Joanne Elizabeth
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    47 Rockleigh Road
    SO16 7AQ Southampton
    Hampshire
    EnglandBritish86411760001
    MCGOWAN, John Peter
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    Amministratore
    Lantern House
    Abbotswood
    WR11 4NS Evesham
    Worcestershire
    British62509010002
    SUNTER, Amanda Jane
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    Amministratore
    664 Rayleigh Road
    Hutton
    CM13 1SJ Brentwood
    Essex
    British44240520002
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    TER 300 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 24 dic 2004
    Consegnato il 12 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name (s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 12 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 24 dic 2004
    Consegnato il 07 gen 2005
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 07 gen 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    Omnibus letter of set-off
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 19 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum standing to the credit of an account,as defined,whether in sterling or any other currency and the debt from time to time owing by the bank represented by that sum and "credit balances"; see form 395 for details. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 19 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or any loan note holder under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (The Trustee)
    Transazioni
    • 19 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 gen 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2002
    Consegnato il 19 dic 2002
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 19 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0