TLLC BRIDGECO10 LIMITED

TLLC BRIDGECO10 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTLLC BRIDGECO10 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04589588
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Kpmg Llp 15 Canada Square
    E14 5GL London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BOXCROFT LIMITED13 nov 200213 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    15 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 26 apr 2016

    15 pagine4.68

    Indirizzo della sede legale modificato da Cavendish House 18 Cavendish Square London W1G 0PJ a Kpmg Llp 15 Canada Square London E14 5GL in data 04 nov 2015

    2 pagineAD01

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    6 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 27 apr 2015

    LRESEX

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Soddisfazione dell'onere 13 in pieno

    4 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 14 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital03 dic 2014

    Stato del capitale al 03 dic 2014

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2013

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2013

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 100
    SH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2012

    16 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Bilancio redatto al 31 mar 2011

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 mar 2009

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2009 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Timothy James Evans il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Nicholas Mark Leslau il 01 ott 2009

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Miss Sandra Louise Gumm il 01 ott 2009

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di TLLC BRIDGECO10 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Segretario
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    AustralianChartered Accountant57113450003
    EVANS, Timothy James
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritishChartered Surveyor104934670002
    GUMM, Sandra Louise
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    EnglandAustralianChartered Accountant57113450003
    LESLAU, Nicholas Mark
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    Amministratore
    Canada Square
    E14 5GL London
    Kpmg Llp 15
    United KingdomBritishCompany Director6815470021
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Segretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Segretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    BritishProperty Director141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Segretario
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    BritishCompany Director93906210001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HARVEY, Paul Victor
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    Amministratore
    4 Hallam Mews
    W1W 6AP London
    United KingdomBritishAccountant116809270002
    HEARN, Grant David
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    Amministratore
    Bishops Platt
    Norlands Lane
    TW20 8SS Thorpe
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director88628480001
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    BritishAccountant53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Amministratore
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritishProperty Director141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    Amministratore
    Southdown Lodge
    43 The Downs Wimbledon
    SW20 8HE London
    United KingdomBritishCompany Director93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    Amministratore
    Mornington House
    40 Parkside
    SW19 5BN London
    United KingdomBritishCompany Director102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    STOREY, Mark
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    Amministratore
    11 Ripon Street
    HP20 2JP Aylesbury
    Buckinghamshire
    BritishDirector Of Treasury & Corpora121960950001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Amministratore
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    BritishDirector80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritishChief Operating Officer166789700001

    TLLC BRIDGECO10 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Assignation of rents
    Creato il 01 giu 2007
    Consegnato il 12 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assignor's entire right,title and interest in the rental income. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 12 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 14/06/2007 and
    Creato il 22 mag 2007
    Consegnato il 21 giu 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H service area A1 old craighall musselburgh t/no MID43086.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 21 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 11 mar 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Security agreement
    Creato il 22 mag 2007
    Consegnato il 11 giu 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to any finance party on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over all property and assets including goodwill bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (Security Agent)
    Transazioni
    • 11 giu 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Assignation of rents dated 1 december 2006 and intimation dated
    Creato il 07 dic 2006
    Consegnato il 20 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The rental income payable under the occupational leases. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC, for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transazioni
    • 20 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental charge
    Creato il 05 dic 2006
    Consegnato il 13 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that property situated at harrow place london l/h t/n NGL636402 together with all buildings and fixtures (including trade fixtures). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The "Security Agent")
    Transazioni
    • 13 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 5 december 2006
    Creato il 01 dic 2006
    Consegnato il 13 dic 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H subjects k/a and forming the travelodge musselburgh service area, A1, old craighall, musselburgh t/no MID43086.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC for Itself as a Secured Party and as Security Trustee for Theother Secured Parties
    Transazioni
    • 13 dic 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 09 nov 2006
    Consegnato il 18 nov 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 18 nov 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 ott 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental leverage debenture relating to the original debenture
    Creato il 06 ott 2003
    Consegnato il 18 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property being :-leasehold land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. 2) leasehold land consisting of the travelodge and little chef situated at the A1 northbound, new fox, south witham. 3) l/h land at shrewsbury road, mile end services, owestry, t/n SL47567.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotand PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transazioni
    • 18 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Supplemental term debenture relating to the original debenture
    Creato il 06 ott 2003
    Consegnato il 18 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor or other obligor to any finance party. Under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The property being the l/h land being land on the east side of derby road, alfreton, derbyshire t/n DY184164. L/h land the travelodge & little chef at A1 northbound, new fox, south witham, colsterworth. L/h land at shrewsbury road, mile end services, oswestry t/n SL47567.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transazioni
    • 18 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Creato il 01 ott 2003
    Consegnato il 21 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 10/10/03 and
    Creato il 01 ott 2003
    Consegnato il 21 ott 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The tenant's interest under the lease dated 4TH february and 4TH march 1991 of musselburgh service area, newcraighall, edinburgh t/n MID43086.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 21 ott 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 18 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All money or liabilities whatsoever due or to become due from any chargor or any other obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Including new fox north,south witham,lincolnshire; DY184164;derby rd,alfreton swanwick;SL47567 and mile end services,oswestry. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC,London as Security Trustee for Itself and the Other Securedparties
    Transazioni
    • 18 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 12 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transazioni
    • 12 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    TLLC BRIDGECO10 LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    27 apr 2015Inizio della liquidazione
    06 dic 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John David Thomas Milsom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Neil David Gostelow
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London
    Praticante
    15 Canada Square
    Canary Wharf
    E14 5GL London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0