TLLC LEVPROPCO1 LIMITED

TLLC LEVPROPCO1 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTLLC LEVPROPCO1 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04590301
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    100 Barbirolli Square
    Manchester
    M2 3AB
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    MALTBAY LIMITED14 nov 200214 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    4 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 045903010004, creata il 29 nov 2013

    148 pagineMR01

    Nomina di Mr Peter Darren Gowers come amministratore in data 25 nov 2013

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Grant David Hearn come amministratore in data 25 nov 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 nov 2013

    Stato del capitale al 05 nov 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    4 pagineAA

    Nomina di Mrs Joanna Boydell come amministratore in data 19 mar 2013

    3 pagineAP01

    Nomina di Joanna Boydell come segretario in data 19 mar 2013

    3 pagineAP03

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come amministratore in data 28 mar 2013

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Jon William Mortimore come segretario in data 28 mar 2013

    2 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    3 pagineAA

    legacy

    16 pagineMG01

    Cessazione della carica di Guy Paul Cuthbert Parsons come amministratore in data 20 apr 2012

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2011 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 dic 2010

    12 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 05 nov 2010 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2009

    15 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    16 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica del Memorandum e/o degli Articoli di Associazione

    RES01
    capital

    Risoluzioni

    Re sect 175 12/03/2010
    RES13

    Dettagli del direttore cambiati per Guy Paul Cuthbert Parsons il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Paul Victor Harvey il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Grant David Hearn il 03 feb 2010

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di TLLC LEVPROPCO1 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    British164373820001
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Segretario
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    BOYDELL, Joanna
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish164373820001
    GOWERS, Peter Darren
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish157443090002
    HARVEY, Paul Victor
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish116809270002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Segretario
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Segretario
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    British141586330001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Segretario
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    British93906210001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Segretario nominato
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    TRAVELREST SERVICES LIMITED
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    Segretario
    Parklands Court 24 Parklands
    Birmingham Great Park Rubery
    B45 9PZ Birmingham
    West Midlands
    42204690005
    HEARN, Grant David
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    EnglandBritish88628480002
    HICKS, Christopher Michael
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    Amministratore
    Valpy Cottage 3 St Andrews Road
    RG4 7PH Reading
    Berkshire
    British53932930001
    JACKSON, Kevin David
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    Amministratore
    Field House
    147 Main Street Sutton Bonington
    LE12 5PE Loughborough
    EnglandBritish141586330001
    LAYTON, Matthew Robert
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    Amministratore delegato nominato
    Flat 49 8 New Crane Wharf
    New Crane Place
    E1W 3TX London
    British900019870001
    MORTIMORE, Jon William
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish93906210001
    PARSONS, Guy Paul Cuthbert
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    Amministratore
    Aylesbury Road
    OX9 3AT Thame
    Sleepy Hollow
    Oxon
    United Kingdom
    United KingdomBritish102187770002
    RICHARDS, Martin Edgar
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    Amministratore delegato nominato
    89 Thurleigh Road
    SW12 8TY London
    British900002870001
    TURL, Simon Charles
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    Amministratore
    Arden House
    Eastwell Road
    LE14 4SS Scalford
    Leicestershire
    British80261230001
    TURNER, Harry
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    Amministratore
    Shepherds Cottage The Vale Golf &
    Country Club Bishampton Fields
    WR10 2LZ Bishampton Near Pershore
    Worcestershire
    EnglandBritish166789700001

    TLLC LEVPROPCO1 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 29 nov 2013
    Consegnato il 05 dic 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Aberdeen airport, burnside drive, off riverview drive, dyce, aberdeen, aberdeenshire t/no ABN84416. Aberdeen bucksburn, A96 inverurie road, bucksburn, aberdeen, abderdeenshire t/no ABN79397. Aberdeen central justice mill lane, justice mill lane, aberdeen t/no ABN107231. Please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 05 dic 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A supplemental debenture
    Creato il 25 ott 2012
    Consegnato il 31 ott 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 31 ott 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Security accession deed
    Creato il 26 set 2006
    Consegnato il 04 ott 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 04 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Security accession deed
    Creato il 04 feb 2003
    Consegnato il 12 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any chargor or any other obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All that property situated at kendrick street, warrington. All that property situated at 1 midpoint, dick lane, pudsey, bradford. All that property situated at riverside, nottingham. For further details of all property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties("Security Agent")
    Transazioni
    • 12 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0