XPERT GROUP LIMITED

XPERT GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàXPERT GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04590730
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di XPERT GROUP LIMITED?

    • Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali

    Dove si trova XPERT GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Third Floor One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Surrey
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di XPERT GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HS142 LIMITED14 nov 200214 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di XPERT GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Quali sono le ultime deposizioni per XPERT GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    16 pagine4.71

    Indirizzo della sede legale modificato da Newton House Cambridge Business Park, Cowley Road Cambridge CB4 0WZ a Third Floor One London Square Cross Lanes Guildford Surrey GU1 1UN in data 09 lug 2015

    2 pagineAD01

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 22 giu 2015

    LRESSP

    Dichiarazione di solvibilità

    3 pagine4.70

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Soddisfazione dell'onere 6 in pieno

    2 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 1 in pieno

    2 pagineMR04

    Cessazione della carica di Anthony Charles Weaver come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Spencer Neal Dredge come amministratore in data 31 dic 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2014 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 dic 2014

    Stato del capitale al 16 dic 2014

    • Capitale: GBP 8,376,935.293058
    SH01

    Nomina di Mr Haywood Chapman come amministratore in data 01 dic 2014

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Spencer Neal Dredge come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Hallett come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital04 dic 2013

    Stato del capitale al 04 dic 2013

    • Capitale: GBP 8,376,935.293058
    SH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2013

    11 pagineAA

    Nomina di Mr Paul Harvey Myhill come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Peter Hayes come segretario

    1 pagineTM02

    Indirizzo della sede legale modificato da * Building B - Office 10 Kirtlington Business Centre, Slade Farm Kirtlington Kidlington Oxfordshire OX5 3JA United Kingdom* in data 17 gen 2013

    1 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 14 nov 2012 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Chi sono gli amministratori di XPERT GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MYHILL, Paul Harvey
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    Segretario
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    175307470001
    CHAPMAN, Haywood Trefor
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    Amministratore
    One London Square
    Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Third Floor
    Surrey
    United KingdomBritish193406100001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Segretario
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    British82233550001
    HAYES, Peter Andrew
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Segretario
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    164935320001
    HAYES, Peter Andrew
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    2 Somersby Crescent
    SL6 3YY Maidenhead
    Berkshire
    British66610550002
    O'RORKE, Nicholas
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Segretario
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    149308060001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Segretario
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    British80721980001
    HS120 LIMITED
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4JJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    Segretario
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4JJ Stoke On Trent
    Staffordshire
    84718670001
    BALAAM, Martin Anthony
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    Amministratore
    The Laurels
    Coole Lane
    CW5 8AY Nantwich
    Cheshire
    United KingdomBritish82233550001
    BARTON, Gary Dean
    132 Hercies Road
    UB10 9ND Hillingdon
    Middlesex
    Amministratore
    132 Hercies Road
    UB10 9ND Hillingdon
    Middlesex
    British87769530001
    BERRY, Grant Rostron
    Bowers Croft
    32 Grove Avenue
    SK9 5EG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    Bowers Croft
    32 Grove Avenue
    SK9 5EG Wilmslow
    Cheshire
    British70957700001
    BROWN, Ian Christopher
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    Fox Hollow
    Westwood Road
    GU20 6LX Windlesham
    Surrey
    EnglandBritish75493580001
    COX, David Michael
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    Amministratore
    Ardshiel
    6 Ladythorn Crescent
    SK7 2HA Bramhall
    Cheshire
    UkBritish33300110001
    CROSS, Ray John
    Dearnford Hall
    SY13 3JJ Whitchurch
    Shropshire
    Amministratore
    Dearnford Hall
    SY13 3JJ Whitchurch
    Shropshire
    UkBritish42422430005
    DREDGE, Spencer Neal
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United KingdomBritish138270950001
    HALLETT, Peter John
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish20621770002
    PERKS, Timothy Howard
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    Amministratore
    Bowdown Farmhouse Burys Bank Road
    Greenham
    RG19 8DA Newbury
    Berkshire
    United KingdomBritish100207880001
    RAMZAN, Mohammed
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    Amministratore
    336 Olton Boulevard West
    B11 3HJ Birmingham
    West Midlands
    British45096260001
    VAN DEN HEUVEL, Christopher Edward Francis, Mr.
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    Amministratore
    7 Hawkes Leap
    GU20 6JL Windlesham
    Surrey
    United KingdomBritish80721980001
    WEAVER, Anthony Charles
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    Amministratore
    Cambridge Business Park, Cowley Road
    CB4 0WZ Cambridge
    Newton House
    United Kingdom
    United KingdomBritish153397180001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish42686850001
    YAPP, Stephen
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Kirtlington Business Centre, Slade Farm
    Kirtlington
    OX5 3JA Kidlington
    Building B - Office 10
    Oxfordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish42686850001
    HEATONS DIRECTORS LIMITED
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4EN Stoke On Trent
    Staffordshire
    Amministratore
    33 Price Street
    Burslem
    ST6 4EN Stoke On Trent
    Staffordshire
    85624460001

    XPERT GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Group debenture
    Creato il 21 giu 2012
    Consegnato il 29 giu 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to each present and future secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 29 giu 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Charge over shares
    Creato il 23 mar 2009
    Consegnato il 27 mar 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the charged securities being name of company in which shares are held: xpert communications limited name of any nominee holder: n/a class of shares held: ordinary no. Of shares held: 299,999 of £1.00 each issued share capital: 299,999 ordinary shares of £1.00 each, name of company in which shares are held: redstone converged solutions limited name of any nominee holder: n/a class of shares held: ordinary no. Of shares held: 1,000 of £1.00 each issued share capital: 102,144 ordinary shares of £1.00 each any related rights, all dividends, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 27 mar 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2009
    • 31 mar 2009
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee & debenture
    Creato il 01 ott 2006
    Consegnato il 13 ott 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2005
    Consegnato il 06 dic 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 06 dic 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 lug 2003
    Consegnato il 24 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited (Securityholder)
    Transazioni
    • 24 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 08 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Development Capital Limited
    Transazioni
    • 08 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 22 set 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Composite guarantee and mortgage debenture
    Creato il 01 feb 2003
    Consegnato il 05 feb 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 05 feb 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 feb 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    XPERT GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    22 giu 2015Inizio della liquidazione
    03 nov 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    John Ariel
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Praticante
    Portland 25 High Street
    RH10 1BG Crawley
    West Sussex
    Terence Guy Jackson
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford
    Praticante
    Third Floor One London Square Cross Lanes
    GU1 1UN Guildford

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0