JNP VENTURES 2 LIMITED

JNP VENTURES 2 LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàJNP VENTURES 2 LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04602538
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di JNP VENTURES 2 LIMITED?

    • Società non commerciali (74990) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    United Kingdom
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JARVISHELF 39 LIMITED27 nov 200227 nov 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Andrew Latham Nelson il 25 nov 2021

    2 pagineCH01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    14 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Paul Birch il 16 gen 2020

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Andrew Lee Milner come amministratore in data 12 dic 2019

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2018

    11 pagineAA

    Dettagli del segretario cambiati per Sherard Secretariat Services Limited il 02 set 2019

    1 pagineCH04

    Indirizzo della sede legale modificato da The Sherard Building Edmund Halley Road Oxford OX4 4DQ a Chancery Exchange 10 Furnival Street London EC4A 1AB in data 02 set 2019

    1 pagineAD01

    Modifica dei dettagli di Amey Tube Limited come persona con controllo significativo il 02 set 2019

    2 paginePSC05

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2019 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2017

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2016

    10 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 15 lug 2017 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Modifica dei dettagli di Amey Tube Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    2 paginePSC05

    Nomina di Mr Paul Birch come amministratore in data 12 mag 2017

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    10 pagineAA

    Nomina di Mr Andrew Lee Milner come amministratore in data 19 feb 2016

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2016 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Segretario
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione5615519
    109588620001
    BIRCH, Paul
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    Amministratore
    142 Speke Road
    L19 2PH Liverpool
    The Matchworks
    England
    England
    United KingdomBritishCorporate Services Director76116640004
    NELSON, Andrew Latham
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    Amministratore
    Chancery Exchange
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Amey
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector36191090004
    HUI, Carol
    GU8
    Segretario
    GU8
    British72371980001
    SECRETARIAT SERVICES LIMITED
    Frogmore Hall
    Frogmore Park
    SG14 3RU Watton On Stone
    Hertfordshire
    Segretario
    Frogmore Hall
    Frogmore Park
    SG14 3RU Watton On Stone
    Hertfordshire
    70053320011
    CARLISLE, Celia Diana
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    Amministratore
    163 Portland Road
    W11 4LR London
    United KingdomBritishProject Financier63756390001
    COPELAND, Ian Christopher
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    Amministratore
    Oakwood
    One Pine Street Apartment 2002
    FOREIGN San Francisco
    California 94111
    Usa
    UsaCompany Director80111500002
    CORBIN, Brian James
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    Amministratore
    71 Woodwarde Road
    Dulwich Village
    SE22 8UN London
    BritishBusiness Executive87942120001
    COTTRELL, Keith
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritishInvestment Manager88691090005
    DOVE, Robert Wallace
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Tara Cavendish Road
    Saint Georges Hill
    KT13 0JT Weybridge
    Surrey
    BritishManaging Director80507460001
    EWELL, Melvyn
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishDirector61515760002
    FENTON, Christopher Victor
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritishManaging Director114610580002
    GARTSHORE, Andrew Robert
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    Amministratore
    6 Jerningham Road
    Telegraph Hill
    SE14 5NX London
    New ZealanderBusiness Executive87942040001
    JOHNSON, Robert Nigel
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    Amministratore
    16 Kirkwell
    Bishopthorpe
    YO23 2RZ York
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector57954340003
    LEO, Jose
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    Amministratore
    The Sherard Building
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    Oxfordshire
    SpanishGroup Finance Director93348510004
    MALARKEY, John Murray
    The Beeches
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    Amministratore
    The Beeches
    Waterhouse Lane
    KT20 6HT Kingswood
    Surrey
    AmericanProject Financier85773840001
    MASON, Geoffrey Keith Howard
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Downing House
    Lower Road
    SG8 0EG Croydon Royston
    Cambridgeshire
    United KingdomBritishChartered Secretary37404250003
    MAWDSLEY, Alan Dean
    6 Nepean Street
    SW15 5DW London
    Amministratore
    6 Nepean Street
    SW15 5DW London
    Us CitizenDirector47237210001
    MELLOR, Margaret Louise
    51 Forest Side
    Chingford
    E4 6BA London
    Amministratore
    51 Forest Side
    Chingford
    E4 6BA London
    United KingdomBritishChartered Secretary80354780001
    MILNER, Andrew Lee
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    Amministratore
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Civil Engineer133714170002
    MILNER, Andrew Lee
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    Amministratore
    Edmund Halley Road
    OX4 4DQ Oxford
    The Sherard Building
    EnglandBritishChartered Civil Engineer133714170002
    MOGG, Charles Michael
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Amministratore
    Ladywood Stray
    Church Road, Wilmcote
    CV37 9XD Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    BritishDirector87961010001
    REES, Paul Meredith
    32 Oxford Road
    Littlemore
    OX4 4PE Oxford
    Amministratore
    32 Oxford Road
    Littlemore
    OX4 4PE Oxford
    United KingdomBritishBusiness Executive96767270001
    ROEHL, Jeffrey Stewart
    2247 Clay Street
    San Francisco
    Ca 94115
    Usa
    Amministratore
    2247 Clay Street
    San Francisco
    Ca 94115
    Usa
    AmericanCompany Director99299140001
    SUTHERLAND, Douglas Iain
    Claro House Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Claro House Stratton Chase Drive
    HP8 4NS Chalfont St Giles
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCivil Servant257902560001
    WICKERSON, Richard John
    80 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PG London
    Amministratore
    80 Madrid Road
    Barnes
    SW13 9PG London
    United KingdomBritishCompany Director54758760002

    Chi sono le persone con controllo significativo di JNP VENTURES 2 LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    06 apr 2016
    10 Furnival Street
    EC4A 1AB London
    Chancery Exchange
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione4602869
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    JNP VENTURES 2 LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Account charge
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 08 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Uic International Ii Limited
    Transazioni
    • 08 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Account charge
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 07 gen 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The account held by the company with the deposit bank. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Uic International Ii Limited (The "Secured Party")
    Transazioni
    • 07 gen 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Second ranking account charge
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 24 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee (secured party) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Credit balance from time to time in the relevant accounts (and any renewal or redesignation thereof) maintained with the deposit bank by the company and all rights,benefits and proceeds in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jarvis PLC (The Secured Party)
    Transazioni
    • 24 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    First ranking account charge
    Creato il 23 dic 2002
    Consegnato il 24 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations due or to become due from the company to the chargee (secured party) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Credit balance from time to time in the relevant accounts (and any renewal or redesignation thereof) maintained with the deposit bank by the company and all rights,benefits and proceeds in respect thereof.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jarvis PLC (The Secured Party)
    Transazioni
    • 24 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An account charge
    Creato il 21 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge and with full title guarantee the deposit being the credit balance from time to time in the JNPV2 (l/c 13) collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Trustee for and on Behalf of the Securedparties
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A deposit agreement and account charge
    Creato il 21 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge and with full title guarantee the deposit being the deposit balance from time to time of the JNPV2 collection account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Trustee for and on Behalf of the Securedparties
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    An account charge
    Creato il 21 dic 2002
    Consegnato il 23 dic 2002
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligors to the secured parties or the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge and with full title guarantee the deposit being the credit balance from time to time in the JNPV2 (l/c 11 and 12) collateral account. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC in Its Capacity as Trustee for and on Behalf of the Securedparties
    Transazioni
    • 23 dic 2002Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 mar 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0