DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED

DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDOMES OF SILENCE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04611280
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Bickerton House C/O Pemberton Capital Llp
    25 Bickerton Road
    N19 5JU London
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DIRECT MESSAGE GROUP LIMITED04 feb 200304 feb 2003
    WEAVETOWER LIMITED06 dic 200206 dic 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al29 giu 2018

    Quali sono le ultime deposizioni per DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Oliver Charles Tonkin come amministratore in data 28 giu 2019

    1 pagineTM01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 29 giu 2018

    2 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd England a Bickerton House C/O Pemberton Capital Llp 25 Bickerton Road London N19 5JU in data 28 set 2018

    1 pagineAD01

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2018 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 30 giu 2017

    8 pagineAA

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 30 giu 2017 al 29 giu 2017

    1 pagineAA01

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Dichiarazione di conformità presentata il 20 mag 2017 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Notifica di Domes of Silence Holdings Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016

    1 paginePSC02

    Indirizzo della sede legale modificato da 18-19 Princewood Road Corby Northamptonshire NN17 4AP a C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor 207 Regent Street London W1B 4nd in data 15 ago 2017

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Alan John Simpson come segretario in data 14 ago 2017

    1 pagineTM02

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Martin Anthony Cooke come amministratore in data 25 ago 2016

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Michael Siegfried Meyer come amministratore in data 25 ago 2016

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 30 giu 2016

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2016 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital08 lug 2016

    Stato del capitale al 08 lug 2016

    • Capitale: GBP 20,022,169
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2015

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital20 mag 2015

    Stato del capitale al 20 mag 2015

    • Capitale: GBP 20,022,169
    SH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Alan John Simpson il 20 mag 2015

    1 pagineCH03

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 20 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital23 mag 2014

    Stato del capitale al 23 mag 2014

    • Capitale: GBP 20,022,169
    SH01

    Bilancio redatto al 30 giu 2013

    18 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    COOKE, Martin Anthony
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Segretario
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Irish87347070001
    FOWLER, Sean Martin
    5 Lanchester Green
    The Chesters
    NE22 6JP Bedlington
    Northumberland
    Segretario
    5 Lanchester Green
    The Chesters
    NE22 6JP Bedlington
    Northumberland
    British98759900001
    MOLLEKIN, Stuart James
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    Segretario
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    British36939710003
    SIMPSON, Alan John
    18-19 Princewood Road
    Corby
    NN17 4AP Northamptonshire
    Segretario
    18-19 Princewood Road
    Corby
    NN17 4AP Northamptonshire
    British82321910002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COOKE, Martin Anthony
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    Amministratore
    Uggool
    Moycullen
    Galway
    Ireland
    IrelandIrish87347070001
    HARDMAN, Andrew George
    9 Sarah West Close
    NR2 2TE Norwich
    Norfolk
    Amministratore
    9 Sarah West Close
    NR2 2TE Norwich
    Norfolk
    United KingdomBritish44617960003
    MEYER, Michael Siegfried
    53 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    Amministratore
    53 Chelsea Crescent
    Chelsea Harbour
    SW10 0XB London
    EnglandBritish1488770001
    MOLLEKIN, Stuart James
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    Amministratore
    47 Amberhill Way
    Worsley
    M28 1YJ Manchester
    EnglandBritish36939710003
    TONKIN, Oliver Charles
    C/O Pemberton Capital Llp
    25 Bickerton Road
    N19 5JU London
    Bickerton House
    England
    Amministratore
    C/O Pemberton Capital Llp
    25 Bickerton Road
    N19 5JU London
    Bickerton House
    England
    United KingdomBritish132929440001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    207 Regent Street
    W1B 4ND London
    C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor
    England
    06 apr 2016
    207 Regent Street
    W1B 4ND London
    C/O Pemberton Capital Llp, 5th Floor
    England
    No
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland And Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione05458736
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    DOMES OF SILENCE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Guarantee & debenture
    Creato il 29 nov 2010
    Consegnato il 16 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    £1,495,000.50 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Pemcap Acquisitions Limited & Pemcap Investments Limited
    Transazioni
    • 16 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 12 mag 2010
    Consegnato il 28 mag 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the obligor or any member of the group to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centric Spv 1 Limited
    Transazioni
    • 28 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 22 mag 2008
    Consegnato il 28 mag 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 28 mag 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 26 ago 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 28 mar 2006
    Consegnato il 30 mar 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to brillington limited, tim bohan limited and maria murphy
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Brillington Limited, Tim Bohan Limited and Maria Murphy
    Transazioni
    • 30 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Fixed and floating charge
    Creato il 16 gen 2006
    Consegnato il 17 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage all property, by way of fixed charge the f/h and l/h properties all fixtures and fittings and fixed plant and machinery all goodwill unpaid and/or uncalled capital all intellectual property all stocks shares bonds and securities all loan capital all non-vesting debts. By way of floating charge all other property assets and rights.
    Persone aventi diritto
    • Euro Sales Finance PLC
    Transazioni
    • 17 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 09 giu 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 14 set 2005
    Consegnato il 29 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Any f/h or l/h property,all fixtures and fittings,all the plant and machinery,vehicles and computer equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Brillington Limited,Tim Bohan Limited and Maria Murphy
    Transazioni
    • 29 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    A security agreement
    Creato il 25 feb 2003
    Consegnato il 06 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from each obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All estates or interests in any freehold or leasehold property now belonging to it, and all group shares held by it and/or any nominee on its behalf and all related rights accruing to the group shares. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 06 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0