HOBBS HEADCO LIMITED
Panoramica
| Nome della società | HOBBS HEADCO LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04613368 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di HOBBS HEADCO LIMITED?
- Società inattiva (99999) / Attività di organizzazioni ed organismi extraterritoriali
Dove si trova HOBBS HEADCO LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Milton Gate 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di HOBBS HEADCO LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 27 mar 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per HOBBS HEADCO LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 27 mar 2021 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Aleksandra Didymiotis come amministratore in data 28 mag 2021 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Catherine Ann Lambert come amministratore in data 28 mag 2021 | 1 pagine | TM01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 mar 2020 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2020 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 30 mar 2019 | 3 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2019 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Nomina di Ms Catherine Ann Lambert come amministratore in data 01 dic 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Anastasia Fadeeva come amministratore in data 01 dic 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Margaret Eve Lustman come amministratore in data 02 gen 2019 | 1 pagine | TM01 | ||
Nomina di James Justin Hampshire come amministratore in data 02 gen 2019 | 2 pagine | AP01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2018 | 5 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2018 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Notifica di Hobbs Holdings No. 4 Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 2 pagine | PSC02 | ||
Cessazione di Hobbs Holdings No.3 Limited come persona con controllo significativo il 06 apr 2016 | 1 pagine | PSC07 | ||
Dettagli del direttore cambiati per Ms Anastasia Fadeeva il 22 ott 2018 | 2 pagine | CH01 | ||
Nomina di Ms Anastasia Fadeeva come amministratore in data 06 apr 2018 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Mehul Tank come amministratore in data 31 mar 2018 | 1 pagine | TM01 | ||
Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 gen 2018 al 31 mar 2018 | 1 pagine | AA01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 10 dic 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Conto per una società dormiente redatto al 28 gen 2017 | 5 pagine | AA | ||
Chi sono gli amministratori di HOBBS HEADCO LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIDYMIOTIS, Aleksandra | Amministratore | Kimber Road SW18 4NX London 55 United Kingdom | England | Polish | 200874440001 | |||||
| HAMPSHIRE, James Justin | Amministratore | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom United Kingdom | England | British | 253963520001 | |||||
| DULIEU, Nicola Joy | Segretario | Sycamore Way CM2 9LZ Chelmsford 13 Essex | British | 77393360001 | ||||||
| EASTEAL, Christopher James | Segretario | Little Wigborough CO5 7RD Colchester Copt Hall Essex | British | 132740310001 | ||||||
| GOOLD, James Edward Ian | Segretario | 10 Old Bailey London EC4M 7NG London | British | 86187610001 | ||||||
| LUSCOMBE, Simon | Segretario | Welbeck Street W1G 0AY London 72 | British | 155632590001 | ||||||
| SAMUEL, Nicolas Michael | Segretario | Newbridge House Kelston Road BA1 3QH Bath | British | 78875220003 | ||||||
| CAMPBELL, Lloyd Anthony | Amministratore | Red Gables 24 Rossett Green Lane HG2 9LH Harrogate North Yorkshire | England | British | 2707710003 | |||||
| DULIEU, Nicola Joy | Amministratore | Welbeck Street W1G 0AY London 72 United Kingdom | United Kingdom | British | 77393360001 | |||||
| EASTEAL, Christopher James | Amministratore | Copt Hall Little Wigborough CO5 7RD Colchester Essex | England | British | 127284180001 | |||||
| FADEEVA, Anastasia | Amministratore | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate | United Kingdom | British | 245030110001 | |||||
| GREAVES, Jonathan Adam Charles Stuttard | Amministratore | 10 Old Bailey EC4M 7NG London | British | 70985410004 | ||||||
| HENRY, Karl | Amministratore | Flat 4 9 Hogarth Road SW5 0QH London | British | 57555480001 | ||||||
| LAMBERT, Catherine Ann | Amministratore | Kimber Road SW18 4NX London 55 United Kingdom | England | British | 247607390001 | |||||
| LUSCOMBE, Simon | Amministratore | Welbeck Street W1G 0AY London 72 United Kingdom | United Kingdom | British | 155762000001 | |||||
| LUSTMAN, Margaret Eve | Amministratore | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate | England | British | 40930620002 | |||||
| SAMUEL, Nicolas Michael | Amministratore | Newbridge House Kelston Road BA1 3QH Bath | United Kingdom | British | 78875220003 | |||||
| SILVESTER, Steven William James | Amministratore | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 80015270003 | ||||||
| SPEARING, Michael | Amministratore | Welbeck Street W1G 0AY London 72 United Kingdom | England | British | 86514980001 | |||||
| TANK, Mehul | Amministratore | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate | United Kingdom | British | 222844240001 | |||||
| TROTMAN, Michael Patrick Mayo | Amministratore | 24 Stradella Road SE24 9HA London | England | British | 28018730003 | |||||
| WILLIAMSON, Helen Alison | Amministratore | Welbeck Street W1G 0AY London 72 United Kingdom | United Kingdom | British | 169059300001 | |||||
| WOODHOUSE, Loraine | Amministratore | Welbeck Street W1G 0AY London 72 | England | British | 134205550001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di HOBBS HEADCO LIMITED?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hobbs Holdings No.3 Limited | 06 apr 2016 | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom | Sì | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
| Hobbs Holdings No. 4 Limited | 06 apr 2016 | 60 Chiswell Street EC1Y 4AG London Milton Gate United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
HOBBS HEADCO LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture deed of accession to a debenture dated 2 november 2004 | Creato il 06 dic 2004 Consegnato il 11 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All present and future obligations and liabilities due or to become due from any member of the group to the chargee (as security trustee for the secured parties) (in such capacity the "security trustee") or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Insurance assignment | Creato il 06 dic 2004 Consegnato il 11 dic 2004 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group tot he security trustee and/or the secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari All security and dispositions. All of its right titel and interest to the policy and all monies including bonuses. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Deed of assignment of keyman life policies | Creato il 22 gen 2003 Consegnato il 24 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from any member of the group to the security beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari The policy being st james's place UK PLC policy number 28CW7U52 life assured nick samuel sum assured £500,000 term 5 years and all monies including bonuses accrued or which may at any time after 22 january accrue which shall become payable thereunder and the benefit of all powers and remedies for enforcing the same absolutely. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 23 dic 2002 Consegnato il 03 gen 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0