CORPORAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàCORPORAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04615349
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di CORPORAL LIMITED?

    • Altra vendita al dettaglio di nuovi beni in negozi specializzati (non gallerie d'arte commerciali e ottici) (47789) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova CORPORAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di CORPORAL LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    DE FACTO 1041 LIMITED12 dic 200212 dic 2002

    Quali sono gli ultimi bilanci di CORPORAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per CORPORAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per CORPORAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    4 pagineDS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 12 nov 2014

    • Capitale: GBP 1
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share premium account cancelled 11/11/2014
    RES13

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    18 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2014 con elenco completo degli azionisti

    10 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    19 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 04 mag 2013 con elenco completo degli azionisti

    12 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Gudjon Karl Reynisson il 20 mar 2013

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alasdair Andrew Dunn il 22 mar 2013

    2 pagineCH01

    Nomina di Shoosmiths Secretaries Limited come segretario in data 27 feb 2013

    2 pagineAP04

    Cessazione della carica di Alasdair Andrew Dunn come segretario in data 26 feb 2013

    1 pagineTM02

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Rudolph Hidalgo il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Jean Marie Robert Le Francois Des Courtis il 17 set 2012

    2 pagineCH01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato

    1 pagineAD02

    Bilancio consolidato redatto al 31 mar 2012

    29 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione di modifica degli Articoli di Associazione

    RES01

    Esercizio contabile in corso abbreviato dal 25 mar 2013 al 31 dic 2012

    1 pagineAA01

    Bilancio annuale redatto al 22 set 2012 con elenco completo degli azionisti

    9 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alasdair Andrew Dunn il 22 set 2012

    2 pagineCH01

    Cessazione della carica di Lilja Bjork Einarsdottir come amministratore in data 17 set 2012

    2 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di CORPORAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    SHOOSMITHS SECRETARIES LIMITED
    500-600 Witan Gate West
    MK9 1SH Milton Keynes
    Witan Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    500-600 Witan Gate West
    MK9 1SH Milton Keynes
    Witan Gate House
    Buckinghamshire
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione3206137
    76282680012
    DUNN, Alasdair Andrew
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Amministratore
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    EnglandBritishFinance Director109323280008
    GRUNBERG, Jean-Michel Victor
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Amministratore
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    United KingdomFrenchDirector172325120001
    HIDALGO, Rudolph
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Amministratore
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    United KingdomFrenchDirector171137010001
    LE FRANCOIS DES COURTIS, Jean Marie Robert
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Amministratore
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    FranceFrenchDirector173348100001
    REYNISSON, Gudjon Karl
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Amministratore
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    United KingdomIcelandicC E O130510730003
    BURFORD, Christopher Victor
    19 Copperfields
    48 The Avenue
    BR3 5ER Beckenham
    Kent
    Segretario
    19 Copperfields
    48 The Avenue
    BR3 5ER Beckenham
    Kent
    BritishAccountant100078720001
    DUNN, Alasdair Andrew
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    Segretario
    C/O Hamleys
    6th Floor
    W1F 7PA 2 Fouberts Place
    London
    BritishFinance Director109323280001
    MATHER, Nicholas Charles Holt
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    Segretario
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    BritishFinance Director135955360001
    PARKER, Ian Robert
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    Segretario
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    BritishFinance Director70871000002
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Segretario nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001
    CURRIE, Paul Anthony
    The Gables
    Green End
    SG11 2PG Braughing
    Amministratore
    The Gables
    Green End
    SG11 2PG Braughing
    EnglandBritishTrading Director80615910001
    DAVIES, Tim Morgan
    Tangier Farm
    Tangier Lane
    TN3 9HE Frant
    East Sussex
    Amministratore
    Tangier Farm
    Tangier Lane
    TN3 9HE Frant
    East Sussex
    United KingdomBritishDirector197113400001
    EINARSDOTTIR, Lilja Bjork
    Floor Old Change House
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    4th
    England
    Amministratore
    Floor Old Change House
    128 Queen Victoria Street
    EC4V 4BJ London
    4th
    England
    EnglandIcelandicHead Of Landsbanki London Branch147225580001
    HARTLEY, Stella Margaret
    61 Popes Avenue
    Trawberry Hill
    TW2 5TD Twickenham
    Middlesex
    Amministratore
    61 Popes Avenue
    Trawberry Hill
    TW2 5TD Twickenham
    Middlesex
    BritishMarketing Director116836250001
    HUSTAD, Hans Kristian
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    Amministratore
    Nygaards Alle 5,
    FOREIGN Oslo
    0871
    Norway
    NorwegianDirector103594230001
    INGLESON, Sally
    Baring Road
    SO23 0JN Winchester
    Hillbrow House
    Hampshire
    Amministratore
    Baring Road
    SO23 0JN Winchester
    Hillbrow House
    Hampshire
    UkBritishDirector137610960001
    JOHANNESSON, Jon Asgeir
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    Amministratore
    Laufasvegur 69
    FOREIGN Reykjavik
    101
    Iceland
    IcelandIcelandicChief Executive Officer78382920001
    LEE, Diane
    Stoke Row
    RG9 5PL Henley On Thames
    Wicketts
    Oxfordshire
    Amministratore
    Stoke Row
    RG9 5PL Henley On Thames
    Wicketts
    Oxfordshire
    United KingdomBritishDirector196229040001
    MAR HALLDORSSON, Petur
    Graenamyri 1
    170 Seltjarnarnes
    Iceland
    Amministratore
    Graenamyri 1
    170 Seltjarnarnes
    Iceland
    IcelandIcelandicDirector115006030001
    MATHER, Nicholas Charles Holt
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    Amministratore
    Cutmill
    Bosham
    PO18 8PS Chichester
    Newells House
    West Sussex
    United KingdomBritishFinance Director135955360001
    OSBORNE, Katherine Anne
    7 Foster Close
    Cheshunt
    EN8 9RZ Waltham Cross
    Hertfordshire
    Amministratore
    7 Foster Close
    Cheshunt
    EN8 9RZ Waltham Cross
    Hertfordshire
    BritishHuman Resources Manager72141580001
    PARKER, Ian Robert
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    Amministratore
    1 Seymour Road
    W4 5ES London
    BritishFinance Director70871000002
    ROSE, Stuart Anthony
    The Old Farm
    Epping Long Green
    CM16 6QN Epping Green
    Essex
    Amministratore
    The Old Farm
    Epping Long Green
    CM16 6QN Epping Green
    Essex
    EnglandBritishDirector87188070001
    SIGURDSSON, Gunnar
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    Amministratore
    4 Greenlink Walk
    Kew Riverside
    TW9 4AF Richmond Upon Thames
    London
    EnglandIcelandicDirector114179720001
    SIGURDSSON, Gunnar
    Heidarhjalli 22
    200 Kopavogur
    Iceland
    Amministratore
    Heidarhjalli 22
    200 Kopavogur
    Iceland
    IcelandicFinancial Director102492250001
    SZIRTES, Andras
    Flat 6
    87 Marylebone High Street
    W1U 4QU London
    Amministratore
    Flat 6
    87 Marylebone High Street
    W1U 4QU London
    United KingdomHungarianInvestment Director117998660001
    SZIRTES, Andras
    Flat 6
    87 Marylebone High Street
    W1U 4QU London
    Amministratore
    Flat 6
    87 Marylebone High Street
    W1U 4QU London
    United KingdomHungarianDirector117998660001
    THORSTEINSSON, Jon Scheving
    Oddagata 4
    FOREIGN 101 Reykjavik
    Iceland
    Amministratore
    Oddagata 4
    FOREIGN 101 Reykjavik
    Iceland
    IcelandIcelandicManaging Director84698780001
    WATKINSON, John Dudley
    Fir Tree Cottage
    36 West Perry
    PE18 0BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    Amministratore
    Fir Tree Cottage
    36 West Perry
    PE18 0BX Huntingdon
    Cambridgeshire
    BritishChief Operating Officer66949520001
    WOOLFORD, Adrian
    115 Orchard Grove
    Chalfont St Peter
    SL9 9ET Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Amministratore
    115 Orchard Grove
    Chalfont St Peter
    SL9 9ET Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    BritishHead Of Brand Development88584680001
    WRIGHT, Michael Crossley
    Fouberts Place
    W1F 7PA London
    2
    United Kingdom
    Amministratore
    Fouberts Place
    W1F 7PA London
    2
    United Kingdom
    MonacoBritishDirector156047740001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006090001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Amministratore delegato nominato
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    900006100001

    CORPORAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 set 2012
    Consegnato il 26 set 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the parent to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Natixis (In Its Capacity as Security Agent for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 26 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Guarantee & debenture
    Creato il 10 giu 2011
    Consegnato il 15 giu 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 15 giu 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Guarantee & debenture
    Creato il 30 giu 2006
    Consegnato il 08 lug 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H land under t/ns HD425461, NGL390956 and NGL614726. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Trustee for the Finance Parties
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee) as Trustee for the Finance Parties
    Transazioni
    • 08 lug 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Subordination deed
    Creato il 17 giu 2003
    Consegnato il 04 lug 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Until payment is made by the company to the security trustee of any sums received, the company shall hold all such sums on trust for the security trustee. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transazioni
    • 04 lug 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite guarantee and debenture between the company (1), soldier limited (2), and the royal bank of scotland (the security trustee)
    Creato il 17 giu 2003
    Consegnato il 27 giu 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become from the company to the finance parties or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC (Security Trustee)
    Transazioni
    • 27 giu 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 20 set 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0