THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED

THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE SIMPLY SMART GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04627313
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    • Attività di ristorazione per eventi (56210) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Devon House
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    JOYCOUNT LIMITED02 gen 200302 gen 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2017

    Quali sono le ultime deposizioni per THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2017

    19 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2018 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 11 gen 2018

    • Capitale: GBP 0.01
    3 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 7 in pieno

    4 pagineMR04

    Bilancio redatto al 31 dic 2016

    18 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 02 gen 2017 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Parte della proprietà o attività è stata liberata e non fa più parte dell'onere 7

    5 pagineMR05

    Bilancio redatto al 31 dic 2015

    15 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Stato del capitale al 03 feb 2016

    • Capitale: GBP 3,200.49
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06
    capital

    Risoluzioni

    Share prem a/c reduced to nil 21/12/2015
    RES13

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 giu 2015 al 31 dic 2015

    1 pagineAA01

    Bilancio redatto al 30 giu 2014

    13 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 02 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital02 feb 2015

    Stato del capitale al 02 feb 2015

    • Capitale: GBP 3,481,071.33
    SH01

    Dettagli del direttore cambiati per Sir Francis Henry Mackay il 01 feb 2014

    2 pagineCH01

    Chi sono gli amministratori di THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    WATSON, Barnaby
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    Essex
    England
    Segretario
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    Essex
    England
    179590930001
    MACKAY, Francis Henry, Sir
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    Essex
    England
    Amministratore
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    Essex
    England
    EnglandBritish146047710002
    WATSON, Barnaby Hugh Cochrane
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    Essex
    England
    Amministratore
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    Essex
    England
    EnglandBritish106967650002
    BREWSTER, Nigel David
    Lynden Hall
    Langworthy Lane
    SL6 2HH Maidenhead
    Berkshire
    Segretario
    Lynden Hall
    Langworthy Lane
    SL6 2HH Maidenhead
    Berkshire
    British108722900001
    IVES, Stacie Jane
    Mountney Bridge Industrial Estate
    Eastbourne Road Westham
    BN24 5NH Pevensey
    53
    East Sussex
    United Kingdom
    Segretario
    Mountney Bridge Industrial Estate
    Eastbourne Road Westham
    BN24 5NH Pevensey
    53
    East Sussex
    United Kingdom
    155093690001
    MORLEY, Ronald
    Fountain House
    4 South Parade
    LS1 5QX Leeds
    Suite 7
    United Kingdom
    Segretario
    Fountain House
    4 South Parade
    LS1 5QX Leeds
    Suite 7
    United Kingdom
    173875580001
    WATSON, Barnaby Hugh Cochrane
    Oakwood Cottage
    Brimpton Common
    RG7 4RZ Reading
    Segretario
    Oakwood Cottage
    Brimpton Common
    RG7 4RZ Reading
    British106967650002
    GRAVITAS COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    Segretario
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    48725320001
    SDG SECRETARIES LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Segretario nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023560001
    BREWSTER, Nigel David
    Lynden Hall
    Langworthy Lane
    SL6 2HH Maidenhead
    Berkshire
    Amministratore
    Lynden Hall
    Langworthy Lane
    SL6 2HH Maidenhead
    Berkshire
    EnglandBritish108722900001
    DAVIES, Richard John
    Virginia Cottage
    Houghton
    SO20 6LU Stockbridge
    Hampshire
    Amministratore
    Virginia Cottage
    Houghton
    SO20 6LU Stockbridge
    Hampshire
    British91836020001
    ROESTENBURG, Antony Adriaan
    Maplehurst Barn
    Frittenden Road
    TN12 0DL Staplehurst
    Kent
    Amministratore
    Maplehurst Barn
    Frittenden Road
    TN12 0DL Staplehurst
    Kent
    United KingdomBritish79169180001
    THOMAS, Nicholas Edward Heale
    Fountain House
    4 South Parade
    LS1 5QX Leeds
    Suite 7
    United Kingdom
    Amministratore
    Fountain House
    4 South Parade
    LS1 5QX Leeds
    Suite 7
    United Kingdom
    United KingdomBritish162862500001
    WALLIS, Stuart Michael
    Lgc
    Queens Road
    TW11 0LY Teddington
    Middlesex
    Amministratore
    Lgc
    Queens Road
    TW11 0LY Teddington
    Middlesex
    British10075160004
    WATSON, Barnaby Hugh Cochrane
    Oakwood Cottage
    Brimpton Common
    RG7 4RZ Reading
    Amministratore
    Oakwood Cottage
    Brimpton Common
    RG7 4RZ Reading
    EnglandBritish106967650002
    GRAVITAS NOMINEES LIMITED
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    Amministratore
    110 Cannon Street
    EC4N 6AR London
    78501810001
    SDG REGISTRARS LIMITED
    120 East Road
    N1 6AA London
    Amministratore delegato nominato
    120 East Road
    N1 6AA London
    900023550001

    Chi sono le persone con controllo significativo di THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    England
    06 apr 2016
    Anchor Street
    CM2 0GD Chelmsford
    Devon House
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleCompanies Act
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione07403174
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    THE SIMPLY SMART GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 17 dic 2012
    Consegnato il 22 dic 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 22 dic 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 15 dic 2016Parte della proprietà o dell'impresa è stata liberata e non fa più parte dell'ipoteca (MR05)
    • 05 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 16 nov 2009
    Consegnato il 01 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company or any other group company to the chargee or the security beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Equity Harvest Fund (In Its Capacity as the Security Trustee Acting Through Its Nominee Dunedin (Sape Gp) Nominees LTD)
    Transazioni
    • 01 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 17 feb 2006
    Consegnato il 23 feb 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    £25,679.63.
    Persone aventi diritto
    • C I Tower Investments Limited
    Transazioni
    • 23 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 feb 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Guarantee and debenture
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 19 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of charge over credit balances
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 19 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Account no 20996327. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 19 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 18 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture between (1) the chargor, london catering services (2003) limited and by word of mouth limited and (2) sand aire private equity limited
    Creato il 07 mar 2003
    Consegnato il 15 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by any group company to the security trustee or to the security beneficiaries or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Sand Aire Private Equity Limited as Security Trustee
    Transazioni
    • 15 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 19 nov 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0