THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED

THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàTHE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04632281
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED?

    • Altre attività di supporto alle imprese n.c.a. (82990) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Norcliffe House
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2014

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio redatto al 31 dic 2014

    13 pagineAA

    legacy

    1 pagineSH20

    Stato del capitale al 05 ott 2015

    • Capitale: GBP 128.60
    4 pagineSH19

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Dettagli del direttore cambiati per Ian Richard Smith il 19 feb 2015

    2 pagineCH01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Benjamin Robert Taberner il 18 feb 2015

    2 pagineCH01

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2015 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 feb 2015

    Stato del capitale al 09 feb 2015

    • Capitale: GBP 1,286,001
    SH01

    Cessazione della carica di Dominic Jude Kay come amministratore in data 31 ott 2014

    1 pagineTM01

    Bilancio redatto al 31 dic 2013

    14 pagineAA

    Cessazione della carica di Dominic Kay come segretario

    1 pagineTM02

    Nomina di Mrs Abigail Mattison come segretario

    2 pagineAP03

    Dettagli del direttore cambiati per Maureen Claire Royston il 22 mag 2014

    2 pagineCH01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Emerson Court Alderley Road Wilmslow Cheshire SK9 1NX* in data 21 feb 2014

    1 pagineAD01

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2014 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital16 gen 2014

    Stato del capitale al 16 gen 2014

    • Capitale: GBP 1,286,001
    SH01

    Nomina di Maureen Claire Royston come amministratore

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Calveley come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Ian Richard Smith come amministratore

    2 pagineAP01

    Bilancio redatto al 31 dic 2012

    14 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 09 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio redatto al 31 dic 2011

    14 pagineAA

    Risoluzioni

    Resolutions
    33 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Chi sono gli amministratori di THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    MATTISON, Abigail
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    Segretario
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United Kingdom
    188580730001
    ROYSTON, Maureen Claire, Dr
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    Amministratore
    Alderley Road
    Wilmslow
    SK9 1NX Cheshire
    Emerson Court
    England
    England
    United KingdomBritish184190020002
    SMITH, Ian Richard
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish181082310001
    TABERNER, Benjamin Robert
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    Amministratore
    Station Road
    SK9 1BU Wilmslow
    Norcliffe House
    United KingdomBritish150511890001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Segretario
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Segretario
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    British145920530001
    WK COMPANY SERVICES LIMITED
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    Segretario
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    101282840001
    ANSTEAD, Hamilton Douglas
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    Amministratore
    5 Heald Court
    34 Hawthorn Lane
    SK9 5DG Wilmslow
    Cheshire
    British107751890001
    CALVELEY, Peter, Dr
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    Amministratore
    Canwick Hill
    Canwick
    LN4 2RF Lincoln
    The Old Vicarage
    Lincolnshire
    United KingdomBritish131468590001
    CROWE, Geoffrey Michael
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    Amministratore
    51 Oakwood Lane
    Bowdon
    WA14 3DL Altrincham
    Cheshire
    British38256680007
    HEYWOOD, Anthony George
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    Amministratore
    Harborough Hall Lane
    CO5 9UA Messing
    Harborough Hall
    Essex
    EnglandBritish131288260001
    KAY, Dominic Jude
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    Amministratore
    4 Glyn Avenue
    WA15 9DG Hale
    Cheshire
    United KingdomBritish145920530001
    MITCHELL, Nicholas John
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Amministratore
    Lymbrook
    53 Dore Road Dore
    S17 3NA Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritish145102120001
    WK INCORPORATIONS LIMITED
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    Amministratore
    5 & 6 Northumberland Building
    Queen Square
    BA1 2JE Bath
    Avon
    101282830001

    THE HUNTERCOMBE EDINBURGH HOSPITAL LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 09 gen 2006
    Consegnato il 18 gen 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 18 gen 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 lug 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Rhyme debenture
    Creato il 12 nov 2004
    Consegnato il 30 nov 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited
    Transazioni
    • 30 nov 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 27 gen 2006Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 22/11/04 and
    Creato il 11 nov 2004
    Consegnato il 01 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the chargee on any acount whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Binny house ecclesmachan broxburn t/no WLN28510 together with the parts privileges and pertinents thereof the whole right title and interest of the chargor in and to the subjects secured by the charge and the heritable fixtures and fittings therein and thereon.
    Persone aventi diritto
    • Scarlet Finance Limited (The Lender)
    Transazioni
    • 01 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 dic 2005Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 24 nov 2003
    Consegnato il 04 dic 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 04 dic 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Standard security which was presented in scotland for registration on 5TH august 2003 and
    Creato il 18 giu 2003
    Consegnato il 20 ago 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Binny house ecclesmachan west lothian t/n WLN28510.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Ireland
    Transazioni
    • 20 ago 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 ott 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0