ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED

ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04636360
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    • Acquisto e vendita di immobili propri (68100) / Attività immobiliari
    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Moorfields Corporate Recovery
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TERRACE HILL (CLARENDON ROAD) LIMITED14 gen 200314 gen 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2011

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    21 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 ott 2014

    22 pagine4.68

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    5 pagineLIQ MISC OC

    Nomina di un liquidatore volontario

    2 pagine600

    Ordinanza giudiziaria in materia di insolvenza

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    9 pagineLIQ MISC OC

    Avviso di cessazione di funzioni come liquidatore volontario

    1 pagine4.40

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Avviso di passaggio da amministrazione a liquidazione volontaria dei creditori

    1 pagine2.34B

    Rapporto di avanzamento dell'amministratore fino a 06 mag 2013

    17 pagine2.24B

    Notifica di approvazione tacita delle proposte

    1 pagineF2.18

    Dichiarazione delle attività con il modulo 2.14B

    6 pagine2.16B

    Dichiarazione della proposta dell'amministratore

    19 pagine2.17B

    Indirizzo della sede legale modificato da * the Academy Oakdale Place Harrogate North Yorkshire HG1 2LA* in data 12 nov 2012

    2 pagineAD01

    Nomina di un amministratore

    1 pagine2.12B

    Cessazione della carica di Gary Leigh come amministratore

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital31 gen 2012

    Stato del capitale al 31 gen 2012

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2011

    6 pagineAA

    Nomina di Mr Shaun Timothy Taylor come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Stephen Catton come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio annuale redatto al 14 gen 2011 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 mar 2010

    6 pagineAA

    Memorandum e Statuto

    12 pagineMEM/ARTS

    Risoluzioni

    Resolutions
    4 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Amendment agreement 14/07/2010
    RES13
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    legacy

    3 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    TAYLOR, Shaun Timothy
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Moorfields Corporate Recovery
    Segretario
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Moorfields Corporate Recovery
    161251400001
    SILVER, Mark Simon
    Aigle Noir,
    791 Avenue Des Parcs
    Mougins
    06250
    France
    Amministratore
    Aigle Noir,
    791 Avenue Des Parcs
    Mougins
    06250
    France
    FranceEnglish175447290001
    CATTON, Stephen Frank
    25 Belmont Road
    HG2 0LR Harrogate
    North Yorkshire
    Segretario
    25 Belmont Road
    HG2 0LR Harrogate
    North Yorkshire
    British52890010001
    WALSH, Thomas Gerard
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Segretario
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Irish48520230001
    PARK CIRCUS (SECRETARIES) LIMITED
    James Sellars House
    144-146 West George Street
    G2 2HG Glasgow
    Segretario
    James Sellars House
    144-146 West George Street
    G2 2HG Glasgow
    41006000002
    WATERLOW SECRETARIES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Segretario nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003950001
    GRUNDY, Kenneth Wright
    Benington Bury Farm
    SG2 7LN Benington
    Hertfordshire
    Amministratore
    Benington Bury Farm
    SG2 7LN Benington
    Hertfordshire
    British76948310001
    LEIGH, Gary Marc
    Nassington Road
    Hampshead
    NW3 2TY London
    51
    Amministratore
    Nassington Road
    Hampshead
    NW3 2TY London
    51
    United KingdomBritish72496030006
    TURNBULL, Nigel James Cavers
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    Amministratore
    17 Salisbury Avenue
    AL5 2QF Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish1604580001
    WALSH, Thomas Gerard
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    Amministratore
    26 Flanders Road
    Chiswick
    W4 1NG London
    EnglandIrish48520230001
    WATERLOW NOMINEES LIMITED
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    Amministratore delegato nominato
    6-8 Underwood Street
    N1 7JQ London
    900003940001

    ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 16 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    F/H land and buildings k/a 34 clarendon road, watford t/n HD417954. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Securedparties
    Transazioni
    • 16 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Guarantee & debenture
    Creato il 31 gen 2006
    Consegnato il 16 feb 2006
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any obligor to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for the Securedparties
    Transazioni
    • 16 feb 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge over construction documents
    Creato il 18 mar 2003
    Consegnato il 25 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed legal charge all present and future rights, title and interest in and to the contract and the appointments; sums payable by the contractor; any rights arising out of any breach or default by the contractor.. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V. (London Branch)
    Transazioni
    • 25 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 lug 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 18 mar 2003
    Consegnato il 25 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kbc Bank N.V. (London Branch)
    Transazioni
    • 25 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 05 nov 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    ARGYLL VENTURES (CLARENDON ROAD) LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    07 nov 2012Inizio dell'amministrazione
    10 ott 2013Fine dell'amministrazione
    In amministrazione
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    2
    DataTipo
    10 ott 2013Inizio della liquidazione
    06 gen 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Shelley Bullman
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Simon Robert Thomas
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Nicholas H O'Reilly
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London
    Praticante
    88 Wood Street
    EC2V 7QF London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0