AMICUS TECHNOLOGY LIMITED
Panoramica
| Nome della società | AMICUS TECHNOLOGY LIMITED |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04644235 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
- Attività di vigilanza privata (80100) / Attività amministrative e di supporto
Dove si trova AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
| Indirizzo della sede legale | Connaught House 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Essex |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| WCI TECHNOLOGY LIMITED | 24 mar 2003 | 24 mar 2003 |
| RADIOALOFT LIMITED | 22 gen 2003 | 22 gen 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 mar 2012 |
Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
| Bilancio annuale |
|
|---|
Quali sono le ultime deposizioni per AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 3 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti | 7 pagine | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom | 1 pagine | AD02 | ||||||||||
Soddisfazione dell'onere 4 in pieno | 3 pagine | MR04 | ||||||||||
legacy | 3 pagine | MG04 | ||||||||||
Nomina di Mr James William Easton come amministratore | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dimissioni del revisore | 3 pagine | AUD | ||||||||||
Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile | 3 pagine | AA01 | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 40 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomina di Jonathan David Calow come segretario | 3 pagine | AP03 | ||||||||||
Nomina di Mr Michael Robert Parish come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Paul Justin Humphreys come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Nomina di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore | 3 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Gordon come segretario | 2 pagine | TM02 | ||||||||||
Cessazione della carica di Andrew Gardner come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Alan Gordon come amministratore | 2 pagine | TM01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da * Trinity Court Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX* in data 22 nov 2012 | 2 pagine | AD01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012 | 2 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011 | 9 pagine | AA | ||||||||||
Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti | 4 pagine | AR01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Nicholas Chesterfield Gordon il 01 giu 2011 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del segretario cambiati per Mr Alan Nicholas Chesterfield Gordon il 01 giu 2011 | 1 pagine | CH03 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CALOW, Jonathan David | Segretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | British | 173855350001 | ||||||
| EASTON, James William | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 118320980001 | |||||
| HUMPHREYS, Paul Justin | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 33223550003 | |||||
| PARISH, Michael Robert | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 78828750003 | |||||
| PROSSER, Andrew James Mackenzie | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex United Kingdom | England | British | 151240810001 | |||||
| GORDON, Alan Nicholas Chesterfield | Segretario | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | British | 83904050001 | ||||||
| JEFFERY, Peter Robin | Segretario | Shiloh Park Close SO42 7TG Brockenhurst Hampshire | British | 66218710001 | ||||||
| KANDIAH, Andrew Siuam | Segretario | The Old Stables Outlands Lane Curdridge SO30 2HD Botley Hampshire | British | 125608500001 | ||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Segretario nominato | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| GARDNER, Andrew Philip | Amministratore | Romsey Road SO22 5PG Winchester 199 Hampshire United Kingdom | Uk | British | 70433100004 | |||||
| GORDON, Alan Nicholas Chesterfield | Amministratore | 850 The Crescent Colchester Business Park CO4 9QB Colchester Connaught House Essex | United Kingdom | British | 83904050001 | |||||
| HATCHARD, Clive Alan | Amministratore | Myll Cottage Burley Street BH24 4DB Ringwood Hampshire | United Kingdom | British | 152645910001 | |||||
| KANDIAH, Andrew Siuam | Amministratore | The Old Stables Outlands Lane Curdridge SO30 2HD Botley Hampshire | England | British | 125608500001 | |||||
| WINGROVE, Mark | Amministratore | 16 Davidson Close Hythe SO45 6JT Southampton Hampshire | British | 88892340001 | ||||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Amministratore delegato nominato | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 | |||||||
| M & B NOMINEES LIMITED | Amministratore | 11 The Avenue SO17 1XF Southampton Hampshire | 86028110001 |
AMICUS TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 19 apr 2010 Consegnato il 08 mag 2010 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 28 set 2005 Consegnato il 12 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 04 apr 2003 Consegnato il 08 apr 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| All assets debenture deed | Creato il 24 mar 2003 Consegnato il 28 mar 2003 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company formerly known as radioaloft limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0