AMICUS TECHNOLOGY LIMITED

AMICUS TECHNOLOGY LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàAMICUS TECHNOLOGY LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04644235
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    • Attività di vigilanza privata (80100) / Attività amministrative e di supporto

    Dove si trova AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Connaught House 850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Essex
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    WCI TECHNOLOGY LIMITED24 mar 200324 mar 2003
    RADIOALOFT LIMITED22 gen 200322 gen 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2012

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2013 con elenco completo degli azionisti

    7 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital10 lug 2013

    Stato del capitale al 10 lug 2013

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato da Emerald House East Street Epsom Surrey KT17 1HS United Kingdom

    1 pagineAD02

    Soddisfazione dell'onere 4 in pieno

    3 pagineMR04

    legacy

    3 pagineMG04

    Nomina di Mr James William Easton come amministratore

    2 pagineAP01

    Dimissioni del revisore

    3 pagineAUD

    Modifica della data di chiusura dell'esercizio contabile

    3 pagineAA01

    Risoluzioni

    Resolutions
    40 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    incorporation

    Risoluzione del Memorandum di Associazione

    RES01

    Nomina di Jonathan David Calow come segretario

    3 pagineAP03

    Nomina di Mr Michael Robert Parish come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Paul Justin Humphreys come amministratore

    3 pagineAP01

    Nomina di Andrew James Mackenzie Prosser come amministratore

    3 pagineAP01

    Cessazione della carica di Alan Gordon come segretario

    2 pagineTM02

    Cessazione della carica di Andrew Gardner come amministratore

    2 pagineTM01

    Cessazione della carica di Alan Gordon come amministratore

    2 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da * Trinity Court Brunel Road Totton Southampton Hampshire SO40 3WX* in data 22 nov 2012

    2 pagineAD01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2012

    2 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2012 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2011

    9 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 30 giu 2011 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Alan Nicholas Chesterfield Gordon il 01 giu 2011

    2 pagineCH01

    Dettagli del segretario cambiati per Mr Alan Nicholas Chesterfield Gordon il 01 giu 2011

    1 pagineCH03

    Chi sono gli amministratori di AMICUS TECHNOLOGY LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CALOW, Jonathan David
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    British173855350001
    EASTON, James William
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish118320980001
    HUMPHREYS, Paul Justin
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritish33223550003
    PARISH, Michael Robert
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish78828750003
    PROSSER, Andrew James Mackenzie
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United Kingdom
    EnglandBritish151240810001
    GORDON, Alan Nicholas Chesterfield
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Segretario
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    British83904050001
    JEFFERY, Peter Robin
    Shiloh
    Park Close
    SO42 7TG Brockenhurst
    Hampshire
    Segretario
    Shiloh
    Park Close
    SO42 7TG Brockenhurst
    Hampshire
    British66218710001
    KANDIAH, Andrew Siuam
    The Old Stables
    Outlands Lane Curdridge
    SO30 2HD Botley
    Hampshire
    Segretario
    The Old Stables
    Outlands Lane Curdridge
    SO30 2HD Botley
    Hampshire
    British125608500001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    GARDNER, Andrew Philip
    Romsey Road
    SO22 5PG Winchester
    199
    Hampshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Romsey Road
    SO22 5PG Winchester
    199
    Hampshire
    United Kingdom
    UkBritish70433100004
    GORDON, Alan Nicholas Chesterfield
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    Amministratore
    850 The Crescent
    Colchester Business Park
    CO4 9QB Colchester
    Connaught House
    Essex
    United KingdomBritish83904050001
    HATCHARD, Clive Alan
    Myll Cottage
    Burley Street
    BH24 4DB Ringwood
    Hampshire
    Amministratore
    Myll Cottage
    Burley Street
    BH24 4DB Ringwood
    Hampshire
    United KingdomBritish152645910001
    KANDIAH, Andrew Siuam
    The Old Stables
    Outlands Lane Curdridge
    SO30 2HD Botley
    Hampshire
    Amministratore
    The Old Stables
    Outlands Lane Curdridge
    SO30 2HD Botley
    Hampshire
    EnglandBritish125608500001
    WINGROVE, Mark
    16 Davidson Close
    Hythe
    SO45 6JT Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    16 Davidson Close
    Hythe
    SO45 6JT Southampton
    Hampshire
    British88892340001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001
    M & B NOMINEES LIMITED
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    Amministratore
    11 The Avenue
    SO17 1XF Southampton
    Hampshire
    86028110001

    AMICUS TECHNOLOGY LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 19 apr 2010
    Consegnato il 08 mag 2010
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 08 mag 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 22 feb 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 17 apr 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 28 set 2005
    Consegnato il 12 ott 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • World Class International Limited
    Transazioni
    • 12 ott 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 apr 2003
    Consegnato il 08 apr 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 08 apr 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture deed
    Creato il 24 mar 2003
    Consegnato il 28 mar 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as radioaloft limited to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 28 mar 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 13 mag 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0