SALESOUT LTD
Panoramica
| Nome della società | SALESOUT LTD |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata |
| Numero di società | 04646997 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di SALESOUT LTD?
- Trattamento dei dati, hosting e attività correlate (63110) / Informazione e comunicazione
Dove si trova SALESOUT LTD?
| Indirizzo della sede legale | 54 Portland Place W1B 1DY London England |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali sono gli ultimi bilanci di SALESOUT LTD?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2021 |
Quali sono le ultime deposizioni per SALESOUT LTD?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||||||||||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||||||||||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 2 pagine | DS01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2021 | 25 pagine | AA | ||||||||||
Stato del capitale al 27 giu 2022
| 3 pagine | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 pagine | CAP-SS | ||||||||||
Risoluzioni Resolutions | 2 pagine | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da Maxis 1 Western Road Bracknell RG12 1RT England a 54 Portland Place London W1B 1DY in data 26 mag 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Luigi Sacchetti il 20 apr 2022 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Indirizzo della sede legale modificato da 54 Portland Place London W1B 1DY England a Maxis 1 Western Road Bracknell RG12 1RT in data 23 mag 2022 | 1 pagine | AD01 | ||||||||||
Nomina di Mr Luigi Sacchetti come amministratore in data 20 apr 2022 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Anna Christina Torres Gomez come amministratore in data 20 apr 2022 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Bilancio redatto al 31 dic 2020 | 27 pagine | AA | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 feb 2022 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Nomina di Anna Christina Torres Gomez come amministratore in data 01 nov 2021 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Gavin John Thistlethwaite il 07 ott 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Daniel Tullin Finke il 07 ott 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Cessazione della carica di Brian William Coderre come amministratore in data 31 lug 2021 | 1 pagine | TM01 | ||||||||||
Dichiarazione di conformità presentata il 19 feb 2021 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||||||||||
Modifica dei dettagli di Aztec Information Services Holdings Limited come persona con controllo significativo il 10 giu 2020 | 2 pagine | PSC05 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Susan Elizabeth Bennett il 01 gen 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Brian William Coderre il 01 gen 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Dettagli del direttore cambiati per Mr. Kenneth Russell Johns il 01 gen 2021 | 2 pagine | CH01 | ||||||||||
Nomina di Susan Elizabeth Bennett come amministratore in data 18 set 2020 | 2 pagine | AP01 | ||||||||||
Chi sono gli amministratori di SALESOUT LTD?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BROUGHTON SECRETARIES LIMITED | Segretario | Portland Place W1B 1DY London 54 England |
| 86181860001 | ||||||||||
| BENNETT, Susan Elizabeth | Amministratore | Suite 1500 Chicago, Il 60601 203 North Lasalle Street United States | United States | American | 240483090001 | |||||||||
| FINKE, Daniel Tullin, Mr. | Amministratore | Western Road RG12 1RT Bracknell Maxis 1 Berkshire England | United Kingdom | British | 189003760001 | |||||||||
| JOHNS, Kenneth Russell | Amministratore | Suite 1500 Chicago, Il 60601 203 North Lasalle Street United States | United States | American | 181344050001 | |||||||||
| SACCHETTI, Luigi | Amministratore | Western Road RG12 1RF Bracknell Maxis 1 England | England | British,Italian | 294735580001 | |||||||||
| THISTLETHWAITE, Gavin John | Amministratore | Western Road RG12 1RT Bracknell Maxis 1 Berkshire England | England | British | 240467330001 | |||||||||
| MOBERLY, Andrew John | Segretario | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | 163511360001 | |||||||||||
| MOORE, Robert James | Segretario | Montgomery Road Caversfield OX27 8FG Bicester 16 Oxfordshire United Kingdom | British | 131284210001 | ||||||||||
| RICHARDSON, Andrew James Grenville | Segretario | 1 Sandhill Farm Middle Claydon MK18 2LD Buckingham Buckinghamshire | British | 66239460002 | ||||||||||
| VALLANCE, Marcus John | Segretario | Paddock House Little London HP22 4LE Whitchurch Buckinghamshire | British | 89265280002 | ||||||||||
| VAN HULLEN, Rupert | Segretario | 5 Montague Close SE1 9AY London Minerva House | British | 148229790001 | ||||||||||
| WOOD ATKINS, Pascale Edith Marie Anne | Segretario | Hillside 16 East End Weedon HP22 4NJ Aylesbury Buckinghamshire | British | 113684310001 | ||||||||||
| AKINLA, Bernard Akinwale | Amministratore | 1 Arlington Square Downshire Way RG12 1WA Bracknell C/O Information Resources (Uk) Ltd Berkshire England | United Kingdom | British | 246900250001 | |||||||||
| ALBRIGHT, John Merritt | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | Usa | American | 181370140001 | |||||||||
| BARRETT, Helen Joanna | Amministratore | Fernleigh Whitchurch Lane, Oving HP22 4EU Aylesbury Buckinghamshire | British | 126981090001 | ||||||||||
| BRUNT, Darryl Wadeson | Amministratore | 2 Mulberry Court Drayton LE16 8RG Market Harborough Leicestershire | England | British | 108656330001 | |||||||||
| CLARKE, Eugene David | Amministratore | 48 Quenby Way Bromham MK43 8QX Bedford Bedfordshire | British | 126982130001 | ||||||||||
| CODERRE, Brian William | Amministratore | Suite 1500 Chicago, Il 60601 203 North Lasalle Street United States | United States | American | 257977620001 | |||||||||
| COLLINS, Steven Anthony | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | United Kingdom | British | 222880690001 | |||||||||
| COLLINS, Steven Anthony | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | United Kingdom | British | 50054280001 | |||||||||
| DUFFEY, Michael Stephen | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | Usa | American | 131167030001 | |||||||||
| GOMEZ, Anna Christina Torres | Amministratore | Suite 1500 60601 Chicago 203 North Lasalle Street Il United States | United States | American | 290781880001 | |||||||||
| GOUGH, Jennifer Anne | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom | Uk | British | 148229830002 | |||||||||
| KRYSTMAN, Richard | Amministratore | 149 Price George Avenue N14 4TD London | British | 86980280001 | ||||||||||
| KRYSTMAN, Simon Anthony | Amministratore | 96 Pinewood Village Pinelands Cape Town South Africa | South Africa | British | 94540880003 | |||||||||
| MINNS, Gregory Leslie John | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire | United Kingdom | British | 72170360001 | |||||||||
| NAPIER, John Alan | Amministratore | Triton Street Regent's Place NW1 3BF London 10 United Kingdom | United Kingdom | British | 179102060002 | |||||||||
| PRIDAY, Nicholas Charles | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | United Kingdom | British | 115781080003 | |||||||||
| SAMUELS, Michael Julien, Mr. | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire | United States | American | 160950310002 | |||||||||
| SMITH, David Gordon | Amministratore | Renwicks House Chesterfield Close HP17 8PY Stone Bucks | British | 113684350001 | ||||||||||
| VALLANCE, Marcus John | Amministratore | Technology Park, Silverstone Circuit Silverstone NN12 8GX Towcester Silverstone Innovation Centre Northamptonshire England | England | British | 89265280002 | |||||||||
| WILSON, Derek George | Amministratore | Gladwyns Sheering CM22 7LL Bishops Stortford Hertfordshire | England | British | 26355270001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di SALESOUT LTD?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aztec Information Services Holdings Limited | 06 apr 2016 | Portland Place W1B 1DY London 54 England | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
Quali sono le ultime dichiarazioni delle persone con controllo significativo per SALESOUT LTD?
| Notificato il | Cessato il | Dichiarazione |
|---|---|---|
| 19 feb 2017 | 01 feb 2018 | La società non ha ancora completato le misure ragionevoli per determinare se vi sia alcuna persona che sia una persona registrabile o un'entità giuridica rilevante registrabile in relazione alla società. |
SALESOUT LTD ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Creato il 24 apr 2007 Consegnato il 11 mag 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
| Debenture | Creato il 17 ott 2005 Consegnato il 22 ott 2005 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0