EMIZON GROUP LIMITED

EMIZON GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEMIZON GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04687845
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EMIZON GROUP LIMITED?

    • Altre attività di telecomunicazioni (61900) / Informazione e comunicazione

    Dove si trova EMIZON GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Business Innovation Centre
    Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di EMIZON GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per EMIZON GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei membri

    7 pagineLIQ13

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 09 ago 2023

    8 pagineLIQ03

    Indirizzo della sede legale modificato da 67 Grosvenor Street Mayfair London W1K 3JN a Business Innovation Centre Harry Weston Road Coventry CV3 2TX in data 19 gen 2023

    2 pagineAD01

    Indirizzo della sede legale modificato da Building 4, Croxley Park Hatters Lane Watford WD18 8YF England a 67 Grosvenor Street Mayfair London W1K 3JN in data 18 ago 2022

    2 pagineAD01

    Dichiarazione di solvibilità

    5 pagineLIQ01

    Nomina di un liquidatore volontario

    3 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione speciale per la liquidazione al 10 ago 2022

    LRESSP

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2022 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2021

    7 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Indirizzo della sede legale modificato da Salamander Quay West Park Lane Harefield Uxbridge Middlesex UB9 6NZ England a Building 4, Croxley Park Hatters Lane Watford WD18 8YF in data 27 apr 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale redatto al 31 mar 2020

    7 pagineAA

    Cessazione della carica di Vistra Cosec Limited come segretario in data 15 ott 2020

    1 pagineTM02

    Soddisfazione dell'onere 046878450015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 046878450016 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2020 con aggiornamenti

    5 pagineCS01

    Soddisfazione dell'onere 046878450014 in pieno

    1 pagineMR04

    Iscrizione dell'ipoteca 046878450016, creata il 27 set 2019

    59 pagineMR01

    Risoluzioni

    Resolutions
    10 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Directors conduct 05/09/2019
    RES13
    incorporation

    Risoluzione di adozione degli Articoli di Associazione

    RES01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 mar 2019

    8 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 01 ago 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    I registri sono stati trasferiti al luogo di ispezione registrato First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL

    1 pagineAD03

    L'indirizzo di ispezione del registro è stato modificato a First Floor Templeback 10 Temple Back Bristol BS1 6FL

    1 pagineAD02

    Dettagli del segretario cambiati per Jordan Cosec Limited il 05 apr 2019

    1 pagineCH04

    Chi sono gli amministratori di EMIZON GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HEALE, Edward Christopher Fairfax
    Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    Business Innovation Centre
    Amministratore
    Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    Business Innovation Centre
    United KingdomBritishCompany Director212723740001
    LEIGH, Thomas William Elliott
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    United Kingdom
    Amministratore
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector263289450001
    SLUPEK, Jonathan Ryszard
    Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    Business Innovation Centre
    Amministratore
    Harry Weston Road
    CV3 2TX Coventry
    Business Innovation Centre
    EnglandBritishDirector256437200001
    CARTER, Gary Robert
    9 Tamar Way
    RG41 3UB Wokingham
    Segretario
    9 Tamar Way
    RG41 3UB Wokingham
    British50624770003
    DESLER, Gerry
    Chelmsford Road
    CM22 7BD Hatfield Heath
    Stonebridge House
    Essex
    Segretario
    Chelmsford Road
    CM22 7BD Hatfield Heath
    Stonebridge House
    Essex
    British158006470001
    FITZSIMMONS, Christopher David Andrew
    Chatsworth Avenue
    NG25 0AE Southwell
    19
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    Segretario
    Chatsworth Avenue
    NG25 0AE Southwell
    19
    Nottinghamshire
    United Kingdom
    150892420001
    HEALE, Edward
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    Segretario
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    248645820001
    LLOYD, Peter Nicholas
    25 The Mews
    Fitzalan Road
    BN18 9LF Arundel
    West Sussex
    Segretario
    25 The Mews
    Fitzalan Road
    BN18 9LF Arundel
    West Sussex
    BritishAccountant115545160001
    SMYTHE, Gordon Bernard
    The Oast House
    Billet Hill
    TN15 7HE Ash
    Kent
    Segretario
    The Oast House
    Billet Hill
    TN15 7HE Ash
    Kent
    BritishDirector And Secretary88603790001
    SWINGEWOOD, John Paul
    Allerton Road
    Central Park
    CV23 0PA Rugby
    1
    Warwickshire
    United Kingdom
    Segretario
    Allerton Road
    Central Park
    CV23 0PA Rugby
    1
    Warwickshire
    United Kingdom
    162514910001
    PARAMOUNT COMPANY SEARCHES LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Segretario nominato
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001530001
    VISTRA COSEC LIMITED
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    Segretario
    Templeback
    10 Temple Back
    BS1 6FL Bristol
    First Floor
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione06412777
    128256230002
    CARTER, Gary Robert
    6 Walnut Close
    RG41 4BG Wokingham
    Berkshire
    Amministratore
    6 Walnut Close
    RG41 4BG Wokingham
    Berkshire
    BritishDirector50624770001
    DESLER, Gerry
    Chelmsford Road
    CM22 7BD Hatfield Heath
    Stonebridge House
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    Chelmsford Road
    CM22 7BD Hatfield Heath
    Stonebridge House
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant123360960001
    DILLION, Roland
    32 Manse Gardens
    Haslers Lane
    CM6 1BL Great Dunmow
    Essex
    Amministratore
    32 Manse Gardens
    Haslers Lane
    CM6 1BL Great Dunmow
    Essex
    United KingdomBritishDirector126010880002
    DOBLE, David John
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector86978140001
    FAURE, Didier Joseph Andre
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    EnglandBritishDirector87482730002
    FENN, Jeremy Mark
    Allerton Road
    Central Park
    CV23 0PA Rugby
    1
    Warwickshire
    Amministratore
    Allerton Road
    Central Park
    CV23 0PA Rugby
    1
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector69458580005
    FENN, Jeremy Mark
    Stone Rings Grange
    HG2 9HU Harrogate
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Stone Rings Grange
    HG2 9HU Harrogate
    4
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector69458580005
    GIRDLER, Geoffrey William
    16 Turbary Road
    BH22 8AS Ferndown
    Dorset
    Amministratore
    16 Turbary Road
    BH22 8AS Ferndown
    Dorset
    EnglandBritishDirector13954510001
    KNIGHT, Kerry Leigh
    Ram Gorse
    CM20 1PZ Harlow
    92
    Essex
    United Kingdom
    Amministratore
    Ram Gorse
    CM20 1PZ Harlow
    92
    Essex
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Technical Officer113721340003
    LLOYD, Peter Nicholas
    25 The Mews
    Fitzalan Road
    BN18 9LF Arundel
    West Sussex
    Amministratore
    25 The Mews
    Fitzalan Road
    BN18 9LF Arundel
    West Sussex
    EnglandBritishAccountant115545160001
    SMYTHE, Gordon Bernard
    The Oast House
    Billet Hill
    TN15 7HE Ash
    Kent
    Amministratore
    The Oast House
    Billet Hill
    TN15 7HE Ash
    Kent
    United KingdomBritishDirector And Secretary88603790001
    SWINGEWOOD, John Paul
    Allerton Road
    Central Park
    CV23 0PA Rugby
    1
    Warwickshire
    United Kingdom
    Amministratore
    Allerton Road
    Central Park
    CV23 0PA Rugby
    1
    Warwickshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManagement Consultant141447260001
    TUCK, Robert
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    Amministratore
    Park Lane
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    Middlesex
    England
    United KingdomBritishCompany Director113557860002
    TUCK, Robert
    69 Church Road
    NN11 7HQ Braunston
    Northamptonshire
    Amministratore
    69 Church Road
    NN11 7HQ Braunston
    Northamptonshire
    United KingdomBritishManager113557860002
    WARDA, Charles
    11 Emblems
    CM6 2AG Great Dunmow
    Essex
    Amministratore
    11 Emblems
    CM6 2AG Great Dunmow
    Essex
    United KingdomBritishDirector111034980001
    WHITFIELD, Andrew
    Owlthorpe Avenue
    S20 5JS Sheffield
    20
    Yorkshire
    Amministratore
    Owlthorpe Avenue
    S20 5JS Sheffield
    20
    Yorkshire
    EnglandBritishGeheral Manager139535680001
    PARAMOUNT PROPERTIES (UK) LIMITED
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    Amministratore delegato nominato
    229 Nether Street
    N3 1NT London
    900001520001

    Chi sono le persone con controllo significativo di EMIZON GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Csl Communications Group Limited
    Salamander Quay
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    England
    25 apr 2017
    Salamander Quay
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander Quay West
    England
    Forma giuridicaLimited Company
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLimited Liability Company
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione07869409
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    Csl Communications Group Limited
    Salamander Quay
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander
    England
    01 ago 2016
    Salamander Quay
    Harefield
    UB9 6NZ Uxbridge
    Salamander
    England
    No
    Forma giuridicaLtd
    Paese di registrazioneEngland
    Autorità legaleLimited By Shares
    Luogo di registrazioneEngland And Wales
    Numero di registrazione07869409
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.

    EMIZON GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 27 set 2019
    Consegnato il 10 ott 2019
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    This company is not charging the property shown in schedule 2 of this deed.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Natwest Markets PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 10 ott 2019Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ago 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 25 apr 2017
    Consegnato il 02 mag 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Not applicable.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Parties (Security Agent)
    Transazioni
    • 02 mag 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 12 ago 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 30 ago 2016
    Consegnato il 01 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All intellectual property rights over the design, manufacturing know how and approvals for the telecom communication devices - tcd 1 and tcd 2; specified software as per part c of the schedule, and certificates.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Persone aventi diritto
    • Oaknorth Bank Limited (8595042)
    Transazioni
    • 01 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 lug 2020Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 27 feb 2013
    Consegnato il 05 mar 2013
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, all plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Coutts and Company
    Transazioni
    • 05 mar 2013Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 ago 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 20 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The undertaking and all property and assets including goodwill, debts and equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • John Swingewood
    Transazioni
    • 20 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Ross Davies
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All assets and undertaking including all properties goodwill equipment debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Jeremy Fenn
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The undertaking and all property and assets including goodwill, debts, equipment, securities. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Centralnic Limited
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 19 ago 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Alastair Mitchell
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All assets and undertaking including all proeprties goodwill equipment debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Alex Starling
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All assets and undertaking including all properties goodwill equipment debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Charles Richard Hartley
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    All assets and undertaking including all properties goodwill equipment debts see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • South Yorkshire Investment Capital Fund
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Gary Robert Carter
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 04 gen 2011
    Consegnato il 11 gen 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brevi particolari
    The undertaking and all property and assets including goodwill, debts and all equipment see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Andrew Brown
    Transazioni
    • 11 gen 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 06 set 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 12 dic 2008
    Consegnato il 24 dic 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Lease of land at X4, annexe building, sheffield city airport, europa limk, sheffield and a lease of premises at smiths barn, smiths yard, moat farm, welford road, south kilworth, leicestershire. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • South Yorkshire Investment Capital Fund Acting by Yvf Gp (Investment) Limited (the Fund)
    Transazioni
    • 24 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 11 apr 2008
    Consegnato il 24 apr 2008
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Hsbc Bank PLC
    Transazioni
    • 24 apr 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 gen 2013Dichiarazione che parte o tutta la proprietà gravata è stata liberata (MG04)
    • 22 mar 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    EMIZON GROUP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    11 mar 2024Data prevista di scioglimento
    10 ago 2022Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei soci
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Craig Andrew Ridgley
    67 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3JN London
    Praticante
    67 Grosvenor Street
    Mayfair
    W1K 3JN London

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0