HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED

HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04689315
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED?

    • Sviluppo di progetti di costruzione (41100) / Costruzioni

    Dove si trova HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    c/o MILSTED LANGDON LLP
    Winchester House
    Deane Gate Avenue
    TA1 2UH Taunton
    Somerset
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    BASHELFCO 2795 LIMITED06 mar 200306 mar 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al30 nov 2011

    Quali sono le ultime deposizioni per HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Cessazione della carica di Julian Ivor Gillard Ball come amministratore in data 25 set 2013

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2013 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital09 mag 2013

    Stato del capitale al 09 mag 2013

    • Capitale: GBP 999
    SH01

    Indirizzo della sede legale modificato da 2 Drake House Cook Way Taunton Somerset TA2 6BG in data 11 set 2012

    1 pagineAD01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2011

    6 pagineAA

    La procedura di scioglimento d'ufficio è stata interrotta

    1 pagineDISS40

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Julian Ivor Gillard Ball il 15 feb 2012

    2 pagineCH01

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2010

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2009

    4 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 06 mar 2010 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2008

    5 pagineAA

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2007

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    4 pagine363a

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 30 nov 2006

    5 pagineAA

    legacy

    1 pagine288c

    legacy

    7 pagine363s

    legacy

    3 pagine395

    legacy

    2 pagine403a

    legacy

    2 pagine403a

    Chi sono gli amministratori di HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BUCKLEY, Kevan Paul
    201 Earlsfield Road
    Wandsworth
    SW18 3DD London
    Segretario
    201 Earlsfield Road
    Wandsworth
    SW18 3DD London
    BritishCompany Director90625550002
    BUCKLEY, Kevan Paul
    201 Earlsfield Road
    Wandsworth
    SW18 3DD London
    Amministratore
    201 Earlsfield Road
    Wandsworth
    SW18 3DD London
    United KingdomBritishCompany Director90625550002
    HUGHES, Paul Martyn
    Little Oaks
    Staplehay, Trull
    TA3 7HB Taunton
    Somerset
    Amministratore
    Little Oaks
    Staplehay, Trull
    TA3 7HB Taunton
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Director63902300003
    BA CORPSEC LIMITED
    Curzon House
    Southernhay West
    EX1 1JG Exeter
    Devon
    Segretario nominato
    Curzon House
    Southernhay West
    EX1 1JG Exeter
    Devon
    900016790001
    BALL, Julian Ivor Gillard
    Deane Drive
    TA1 5PP Taunton
    73
    Somerset
    United Kingdom
    Amministratore
    Deane Drive
    TA1 5PP Taunton
    73
    Somerset
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director60640100006
    BA CORPDIRECT LIMITED
    Curzon House
    Southernhay West
    EX1 1JG Exeter
    Devon
    Amministratore delegato nominato
    Curzon House
    Southernhay West
    EX1 1JG Exeter
    Devon
    900016780001

    HALLAM HOUSE DEVELOPMENTS LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal mortgage
    Creato il 23 mar 2007
    Consegnato il 28 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Sidford service station high street sidford devon t/no DN433790. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 28 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 26 feb 2007
    Consegnato il 03 mar 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 03 mar 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 27 feb 2004
    Consegnato il 10 mar 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Land at 30 hayfield road (being part of the former rear gardens of 43 and 45 fownes road), alcombe, minehead, somerset being part of the property in t/no ST65510 and ST195966.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 10 mar 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 10 set 2004Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 gen 2004
    Consegnato il 31 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC
    Transazioni
    • 31 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Legal charge
    Creato il 07 gen 2004
    Consegnato il 13 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    By way of first legal mortgage the freehold property being land at periton rise minehead somerset & comprising together the freehold property known as land to the north of periton rise minehead t/n ST51811 & all that freehold property known as land on the west side of periton lane minehead t/n ST52955 and all rights and benefits under each of the development documents and all other contracts deeds undertakings the benefit of all licences, insurance policies by way of fixed charge plant machinery goods by way of floating charge all its undertaking property and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 13 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Charge over cash deposit
    Creato il 07 gen 2004
    Consegnato il 13 gen 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    The credit balance being the amount for the time being standing to the credit of the account, account number: 50005106-04. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Heritable Bank Limited
    Transazioni
    • 13 gen 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 08 mar 2007Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0