LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED

LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04707146
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Linpac Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    West Yorkshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HACKREMCO (NO. 2045) LIMITED21 mar 200321 mar 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 dic 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    1 pagineDS01

    Soddisfazione dell'onere 047071460008 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047071460007 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 5 in pieno

    1 pagineMR04

    Stato del capitale al 08 set 2023

    • Capitale: GBP 1.533141
    5 pagineSH19

    legacy

    1 pagineSH20

    legacy

    1 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzioni

    Cancel share prem a/c 08/09/2023
    RES13
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Bilancio redatto al 31 dic 2021

    28 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2023 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2022 con aggiornamenti

    4 pagineCS01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2020

    13 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 047071460008, creata il 20 set 2021

    10 pagineMR01

    Stato del capitale a seguito di un'emissione di azioni al 10 ago 2021

    • Capitale: GBP 153,314,170
    4 pagineSH01

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di rimozione dei diritti di prelazione

    RES11
    capital

    Risoluzione di assegnazione di titoli

    RES10

    Cessazione della carica di Roxane Manuela Tamas come segretario in data 18 giu 2021

    1 pagineTM02

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Cessazione di Victor Khosla come persona con controllo significativo il 27 mag 2016

    1 paginePSC07

    Notifica di Linpac Group Holdings Ltd come persona con controllo significativo il 27 mag 2016

    2 paginePSC02

    Cessazione della carica di John Alfred Jones come amministratore in data 08 mar 2021

    1 pagineTM01

    Conto per una società dormiente redatto al 31 dic 2019

    9 pagineAA

    Iscrizione dell'ipoteca 047071460007, creata il 28 apr 2020

    8 pagineMR01

    Dichiarazione di conformità presentata il 21 mar 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Chi sono gli amministratori di LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    BARNETT, Adam Richard
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    EnglandBritish154433520001
    FENSOME, Richard James
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    Segretario
    Ravenscroft
    15 Fulmer Drive
    SL9 7HH Gerrards Cross
    Buckinghamshire
    British84096960001
    JOSEPH, Simon Elliot
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Segretario
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    British113862500001
    LENCE, Robert Burton
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    Segretario
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    242529020001
    TAMAS, Roxane Manuela, Ms.
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    4
    England
    Segretario
    Kingdom Street
    W2 6BD London
    4
    England
    264218020001
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Segretario nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    ALLKINS, John Stephen
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish94637290001
    ARROWSMITH, Michael Richard
    3180 Park Square
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    Amministratore
    3180 Park Square
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    EnglandBritish64948610002
    CARR, Nigel Edmund
    3180 Park Square
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    Amministratore
    3180 Park Square
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    United KingdomBritish146677560001
    DARLINGTON, John
    3180 Park Square
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    Amministratore
    3180 Park Square
    Birmingham Business Park
    B37 7YN Birmingham
    United KingdomBritish63191200003
    DAYAN, Daniel Alexander
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    EnglandBritish114867990002
    DURSTON, John
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish156838680001
    JONES, John Alfred, Mr.
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    EnglandBritish67483720001
    JOSEPH, Simon Elliot
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish113862500001
    LANG, Robert Alexander
    6360 River Overlook Drive
    FOREIGN Atlanta Ga30328
    Georgia
    Usa
    Amministratore
    6360 River Overlook Drive
    FOREIGN Atlanta Ga30328
    Georgia
    Usa
    British102537350001
    MELDRAM, David
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish80950780002
    NICHOLLS, Michael Philip
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    United KingdomBritish133570750001
    PAUL, Richard Neil
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish43099210003
    RAY, Stephen Douglas
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    Amministratore
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritish147866070001
    SHANLEY, Patrick
    Stratford Road
    Wootton Wawen
    B95 6AP Henley-In-Arden
    Clover Bank House
    West Midlands
    Amministratore
    Stratford Road
    Wootton Wawen
    B95 6AP Henley-In-Arden
    Clover Bank House
    West Midlands
    EnglandBritish130362780001
    TENTORI, Mark Ian
    Holly Hedges
    Tingrith Road Evershot
    MK17 9EF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Amministratore
    Holly Hedges
    Tingrith Road Evershot
    MK17 9EF Milton Keynes
    Buckinghamshire
    EnglandBritish119564310001
    WILLIAMS, David Arthur
    9 The Crescent
    Hartford
    CW8 1QS Northwich
    Cheshire
    Amministratore
    9 The Crescent
    Hartford
    CW8 1QS Northwich
    Cheshire
    United KingdomBritish16979530001
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Amministratore delegato nominato
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    Chi sono le persone con controllo significativo di LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Wakefield Road
    England
    27 mag 2016
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Wakefield Road
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneUnited Kingdom
    Autorità legaleLaws Of England
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione677556
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.
    Mr Victor Khosla
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    06 apr 2016
    Wakefield Road
    Featherstone
    WF7 5DE Pontefract
    Linpac
    West Yorkshire
    Nazionalità: American
    Paese di residenza: United States
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.
    • La persona ha il diritto, direttamente o indirettamente, di nominare o rimuovere la maggioranza del consiglio di amministrazione della società.

    LINPAC FINANCE (NO.2) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 20 set 2021
    Consegnato il 21 set 2021
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 21 set 2021Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 ott 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 28 apr 2020
    Consegnato il 18 mag 2020
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Bank PLC
    Transazioni
    • 18 mag 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 ott 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 08 lug 2016
    Consegnato il 08 lug 2016
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Coöperatieve Rabobank U.A.
    Transazioni
    • 08 lug 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 03 lug 2017Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Creato il 12 set 2012
    Consegnato il 20 set 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 20 set 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 03 ott 2023Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement dated 25 september 2003 and
    Creato il 31 ago 2011
    Consegnato il 16 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 16 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 giu 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 21 dic 2009
    Consegnato il 23 dic 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag
    Transazioni
    • 23 dic 2009Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 16 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A pledge agreement
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 08 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as hackremco (no.2045) limited to the senior beneficiaries and the mezzanine beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    A special financial instruments account no.1 Bis (the pledged account) opened in the books of picnal france, a french societe par actions simplifiee with a share capital of eur 37,000 whose registered office is at 1, rue favart 75002 paris france registred with the trade registry of paris under number 449 703 941 (the account holder) in which are registred 37,000 shares of the account holder representing 100% of the share capital of the account holder (the shares). See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London
    Transazioni
    • 08 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 22 ago 2003
    Consegnato il 08 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company formerly known as hackremco (no.2045) limited and any other obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London (Acting as the Security Agent)
    Transazioni
    • 08 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 16 gen 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0