WELDED STILLAGES LTD

WELDED STILLAGES LTD

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàWELDED STILLAGES LTD
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04708513
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di WELDED STILLAGES LTD?

    • fabbricazione di locomotive ferroviarie e materiale rotabile (30200) / Industrie manifatturiere

    Dove si trova WELDED STILLAGES LTD?

    Indirizzo della sede legale
    Radbourne
    56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di WELDED STILLAGES LTD?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    TOWERINPUT MANUFACTURING LIMITED25 gen 201125 gen 2011
    TOWERINPUT DISTRIBUTION LIMITED05 gen 200805 gen 2008
    TOWERINPUT (MANUFACTURING) LIMITED13 ott 200313 ott 2003
    TRENTFAST LIMITED24 mar 200324 mar 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di WELDED STILLAGES LTD?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per WELDED STILLAGES LTD?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per WELDED STILLAGES LTD?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Completamento della liquidazione

    1 pagineL64.07

    Ordine del tribunale di liquidazione

    2 pagineCOCOMP

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del supervisore dell'accordo di composizione fino al 23 mag 2014

    14 pagine1.3

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    8 pagineAA

    Notifica al Registro delle imprese dell'accordo di composizione volontario che entra in vigore

    6 pagine1.1

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed towerinput manufacturing LIMITED\certificate issued on 28/02/13
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name28 feb 2013

    Risoluzione di cambio di nome della società il 28 feb 2013

    RES15
    change-of-name28 feb 2013

    Cambio di nome" per delibera

    NM01

    Bilancio annuale redatto al 31 gen 2013 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital13 feb 2013

    Stato del capitale al 13 feb 2013

    • Capitale: GBP 3,401
    SH01

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2012

    8 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    legacy

    9 pagineMG01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 31 dic 2011 al 31 mar 2012

    3 pagineAA01

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 31 dic 2010

    7 pagineAA

    legacy

    6 pagineMG01

    Bilancio annuale redatto al 26 mar 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01

    legacy

    11 pagineMG01

    Nomina di Mr John Christopher Green come amministratore

    3 pagineAP01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 31 mar 2011 al 31 dic 2010

    3 pagineAA01

    Certificato di cambio di nome

    Company name changed towerinput distribution LIMITED\certificate issued on 25/01/11
    3 pagineCERTNM
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    25 gen 2011

    NOTICE OF CHANGE OF NAME NM01 - RESOLUTION

    CONNOT

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    change-of-name

    Risoluzione di cambio di nome della società il 16 dic 2010

    RES15

    Bilancio redatto al 31 mar 2010

    17 pagineAA

    legacy

    3 pagineMG02

    Nomina di Cf Secretaries Limited come segretario

    3 pagineAP04

    Chi sono gli amministratori di WELDED STILLAGES LTD?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    CF SECRETARIES LIMITED
    56 Kenilworth Rd
    CV32 6JW Leamington Spa
    Radbourne
    Warwickshire
    Segretario
    56 Kenilworth Rd
    CV32 6JW Leamington Spa
    Radbourne
    Warwickshire
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione5444397
    155666880001
    GREEN, John Christopher
    56 Kenilworth Rd
    CV32 6JW Leamington Spa
    Radbourne
    Warwickshire
    Amministratore
    56 Kenilworth Rd
    CV32 6JW Leamington Spa
    Radbourne
    Warwickshire
    EnglandBritish23415050001
    RICKARDS, Marc
    167 Old Park Road
    DY1 3NE Dudley
    West Midlands
    Amministratore
    167 Old Park Road
    DY1 3NE Dudley
    West Midlands
    United KingdomBritish5984580001
    GREEN, John Christopher
    Radbourne 56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    Radbourne 56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    British23415050001
    C F SECRETARIES LIMITED
    Radbourne
    56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    Radbourne
    56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    106284720001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    XL SECRETARIES LIMITED
    Radbourne
    56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    Segretario
    Radbourne
    56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    118268550001
    GREEN, John Christopher
    Radbourne 56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    Amministratore
    Radbourne 56 Kenilworth Road
    CV32 6JW Leamington Spa
    Warwickshire
    EnglandBritish23415050001
    MCGOWAN, Neil Grant
    Coverack Way
    Port Solent
    PO6 4SX Portsmouth
    16
    Hampshire
    Amministratore
    Coverack Way
    Port Solent
    PO6 4SX Portsmouth
    16
    Hampshire
    EnglandBritish53786720007
    MGOWAN, Neil Grant
    16 Coverack Way
    Port Solent
    PO6 4SX Portsmouth
    Hampshire
    Amministratore
    16 Coverack Way
    Port Solent
    PO6 4SX Portsmouth
    Hampshire
    British121102100001
    OXLEY, Steven Anthony
    25 Kensington Road
    Birdcage Lane
    HX3 0HN Halifax
    West Yorkshire
    Amministratore
    25 Kensington Road
    Birdcage Lane
    HX3 0HN Halifax
    West Yorkshire
    United KingdomBritish38082370001
    PARSONS, Jennifer Mary
    Loxwood Cottage
    2 Castle Road
    KT13 9QP Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Loxwood Cottage
    2 Castle Road
    KT13 9QP Weybridge
    Surrey
    EnglandBritish474730008
    PARSONS, John Christopher David
    Loxwood Cottage
    2 Castle Road
    KT13 9QP Weybridge
    Surrey
    Amministratore
    Loxwood Cottage
    2 Castle Road
    KT13 9QP Weybridge
    Surrey
    United KingdomBritish11451420009
    RICKARDS, Marc
    167 Old Park Road
    DY1 3NE Dudley
    West Midlands
    Amministratore
    167 Old Park Road
    DY1 3NE Dudley
    West Midlands
    United KingdomBritish5984580001

    WELDED STILLAGES LTD ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 06 feb 2012
    Consegnato il 09 feb 2012
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bibby Financial Services LTD (As Security Trustee)
    Transazioni
    • 09 feb 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 29 gen 2013Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    All assets debenture
    Creato il 30 giu 2011
    Consegnato il 07 lug 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transazioni
    • 07 lug 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 24 nov 2012Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 10 feb 2011
    Consegnato il 17 feb 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 17 feb 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 06 set 2007
    Consegnato il 11 set 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Clydesdale Bank PLC
    Transazioni
    • 11 set 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 29 dic 2010Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 22 mar 2006
    Consegnato il 23 mar 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Liquidity Import Finance Limited (The Security Holder)
    Transazioni
    • 23 mar 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Debenture
    Creato il 21 mar 2006
    Consegnato il 05 apr 2006
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Liquidity Limited (The "Security Holder")
    Transazioni
    • 05 apr 2006Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 mar 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    WELDED STILLAGES LTD ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    24 mag 2013Data della riunione per approvare il CVA
    Accordo volontario di ristrutturazione aziendale (CVA)
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    William Antony Batty
    Antony Batty & Co
    Third Floor
    WC1R 5EF 3 Field Court
    Gray'S Inn London
    Praticante
    Antony Batty & Co
    Third Floor
    WC1R 5EF 3 Field Court
    Gray'S Inn London
    2
    DataTipo
    12 nov 2015Conclusione della liquidazione
    24 set 2014Data della petizione
    10 nov 2014Inizio della liquidazione
    26 feb 2016Data di scioglimento
    Liquidazione coatta
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    The Official Receiver Or Birmingham
    3rd Floor, Cannon House, 18 The Priory Queensway
    B4 6FD Birmingham
    Praticante
    3rd Floor, Cannon House, 18 The Priory Queensway
    B4 6FD Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0