HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED

HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàHI (EDINBURGH NORTH) LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04712766
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    • Alberghi e simili strutture ricettive (55100) / Attività di alloggio e di ristorazione

    Dove si trova HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    Queens Court
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Essex
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    HOLIDAY INN (EDINBURGH NORTH) LIMITED26 mar 200326 mar 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2020

    Quali sono le ultime deposizioni per HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    2 pagineDS01

    Stato del capitale al 22 dic 2021

    • Capitale: GBP 1
    5 pagineSH19

    legacy

    2 pagineSH20

    legacy

    2 pagineCAP-SS

    Risoluzioni

    Resolutions
    2 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital

    Risoluzione di riduzione del capitale sociale emesso

    RES06

    Soddisfazione dell'onere 047127660011 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047127660009 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047127660012 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047127660015 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047127660013 in pieno

    1 pagineMR04

    Cessazione della carica di Gerardus Johannes Schipper come amministratore in data 25 mag 2021

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Raoul Rene Hofland come amministratore in data 25 mag 2021

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr. Jonathan Patrick Braidley come amministratore in data 25 mag 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr. Christopher Andre Kula come amministratore in data 25 mag 2021

    2 pagineAP01

    Nomina di Bhriz Holloway come amministratore in data 25 mag 2021

    2 pagineAP01

    Indirizzo della sede legale modificato da 1 Bartholomew Lane London EC2N 2AX United Kingdom a Queens Court 9-17 Eastern Road Romford Essex RM1 3NG in data 01 giu 2021

    1 pagineAD01

    Bilancio redatto al 31 mar 2020

    17 pagineAA

    Soddisfazione dell'onere 047127660014 in pieno

    1 pagineMR04

    Soddisfazione dell'onere 047127660010 in pieno

    1 pagineMR04

    Dichiarazione di conformità presentata il 26 mar 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Dettagli del segretario cambiati per Intertrust (Uk) Limited il 16 mar 2020

    1 pagineCH04

    Dettagli del direttore cambiati per Mr Raoul Rene Hofland il 16 dic 2020

    2 pagineCH01

    Iscrizione dell'ipoteca 047127660015, creata il 02 dic 2020

    49 pagineMR01

    Chi sono gli amministratori di HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    Segretario
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSocietà a responsabilità limitata del Regno Unito
    Numero di registrazione06307550
    188126550001
    BRAIDLEY, Jonathan Patrick
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Amministratore
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    United KingdomBritish190075510001
    HOLLOWAY, Bhriz
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Amministratore
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    LuxembourgBritish283774730001
    KULA, Christopher Andre
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    Amministratore
    9-17 Eastern Road
    RM1 3NG Romford
    Queens Court
    Essex
    England
    United KingdomBritish,Canadian,German219684180001
    ENGMANN, Catherine
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    Segretario
    18 Rays Avenue
    SL4 5HG Windsor
    Berkshire
    British92722710002
    WILLIAMS, Alison
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    Segretario
    27 Valley Road
    CM11 2BS Billericay
    Essex
    British78744290002
    HAYSMACINTYRE COMPANY SECRETARIES LIMITED
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Segretario
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione4682161
    89121630002
    PAUL HASTINGS ADMINISTRATIVE SERVICES LIMITED
    Ten Bishops Square
    Eighth Floor
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Segretario
    Ten Bishops Square
    Eighth Floor
    E1 6EG London
    Ten
    United Kingdom
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione04131463
    125623230001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Segretario nominato
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    COX, Melanie Rachel
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    Amministratore
    1 The Green
    Bisham
    SL7 1RY Marlow
    Buckinghamshire
    British96139050001
    EKAS, Petra Cecilia Maria
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    Amministratore
    Red Lion Square
    WC1R 4AG London
    26
    United Kingdom
    United KingdomDutch169731050002
    FISH, Andrew John
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    Amministratore
    Cherry Tree Cottage
    Manor Close
    KT24 6SA East Horsley
    Surrey
    EnglandBritish77133450001
    HOFLAND, Raoul Rene
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    NetherlandsDutch279666540001
    MCCARTHY, John Patrick
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    Amministratore
    Regents Park Road
    NW1 8XL London
    120
    United States112396050001
    MCEWAN, Allan Scott
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    Amministratore
    29 Kings Road
    SL4 2AD Windsor
    Berkshire
    United KingdomBritish75569660002
    MILLSTEIN, Lee Scott
    Grosvenor Street
    W1K 3JZ London
    84
    United Kingdom
    Amministratore
    Grosvenor Street
    W1K 3JZ London
    84
    United Kingdom
    United States Of AmericaAmerican174493480001
    MITCHELL, Paul Raymond
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    Amministratore
    Waltons Farm
    Hollygreen Lane
    HP27 9PL Bledlow
    Bucks
    England
    EnglandBritish148147140001
    NABI, Abdul Majid
    EN5
    Amministratore
    EN5
    British88787130001
    NEWMAN, Mark
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    Amministratore
    Flat 7 44 Sloane Street
    SW1X 9LU London
    United KingdomCanadian62529820001
    PEEK, Martinus Johannes Cornelis
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    United Kingdom
    Amministratore
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    United Kingdom
    NetherlandsDutch261169540001
    PEEK, Martinus Johannes Cornelis
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    Amministratore
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11 Old Jewry
    United Kingdom
    NetherlandsDutch261169540001
    PRINCE, Ryan David
    Brompton Road
    SW3 1QP London
    161
    United Kingdom
    Amministratore
    Brompton Road
    SW3 1QP London
    161
    United Kingdom
    United KingdomCanadian85682450074
    SCHIPPER, Gerardus Johannes
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    Amministratore
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    NetherlandsDutch196882380001
    SPRINGETT, Catherine Mary
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    Amministratore
    The Coach House
    32 Kerrison Road Ealing
    W5 5NW London
    United KingdomBritish147336720001
    STOCKS, Nigel Peter
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    Amministratore
    Birdwoods
    School Lane Shackleford
    GU8 6AZ Godalming
    Surrey
    United KingdomBritish147336730001
    VAN OOSTEROM, Sophie
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    Amministratore
    Orlando Road
    SW4 0LD London
    19
    United Kingdom
    United KingdomDutch139801070001
    VAN VLIET, Jasper Jan
    Oude Utrechtseweg
    Baarn
    32
    3743 Kn
    Netherlands
    Amministratore
    Oude Utrechtseweg
    Baarn
    32
    3743 Kn
    Netherlands
    NetherlandsDutch248827580001
    VAN VLIET, Jasper Jan
    Oude Utrechtseweg
    3743 Kn
    Baarn
    32
    Netherlands
    Amministratore
    Oude Utrechtseweg
    3743 Kn
    Baarn
    32
    Netherlands
    NetherlandsDutch248827580001
    VIJSELAAR, Daniel Christopher
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    United Kingdom
    Amministratore
    Old Jewry
    7th Floor
    EC2R 8DU London
    11
    United Kingdom
    United KingdomDutch195333960001
    WINTER, Richard Thomas
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    Amministratore
    33 St Johns Avenue
    Putney
    SW15 6AL London
    United KingdomBritish6308500001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Amministratore delegato nominato
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Chi sono le persone con controllo significativo di HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    06 apr 2016
    Bartholomew Lane
    EC2N 2AX London
    1
    United Kingdom
    No
    Forma giuridicaPrivate Limited Company
    Paese di registrazioneEngland & Wales
    Autorità legaleCompanies Act 2006
    Luogo di registrazioneCompanies House
    Numero di registrazione09449236
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    HI (EDINBURGH NORTH) LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 02 dic 2020
    Consegnato il 07 dic 2020
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch
    Transazioni
    • 07 dic 2020Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 21 dic 2017
    Consegnato il 27 dic 2017
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects known as and forming holiday inn, edinburgh north, 107 queensferry road, edinburgh registered in the land register of scotland under title number MID42893.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch, in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 27 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2017
    Consegnato il 19 dic 2017
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch, in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 19 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 18 dic 2017
    Consegnato il 19 dic 2017
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale, London Branch, in Its Capacity as Security Agent
    Transazioni
    • 19 dic 2017Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 24 giu 2015
    Consegnato il 24 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Société Générale, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 24 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 giu 2015
    Consegnato il 24 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects known as and forming holiday inn, edinburgh north, 107 queensferry road, edinburgh being the whole subjects registered in the land register of scotland under title number MID42893.
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Persone aventi diritto
    • Société Générale, London Branch (As Security Agent)
    Transazioni
    • 24 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 apr 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 12 giu 2015
    Consegnato il 19 giu 2015
    Soddisfatta integralmente
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Societe Generale London Branch as Security Agent
    Transazioni
    • 19 giu 2015Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 21 giu 2021Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 31 mag 2013
    Consegnato il 11 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    All and whole the subjects k/a the holiday inn edinburgh north 107 queensferry road edinburgh t/n MID42893. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag London Branch for Itself as Security Trustee for the Common Parties
    Transazioni
    • 11 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 04 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 04 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 04 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutsche Bank Ag, London Branch
    Transazioni
    • 04 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 22 mag 2013
    Consegnato il 03 giu 2013
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Deutshce Bank Ag, London Branch (The Common Security Agent)
    Transazioni
    • 03 giu 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 14 apr 2015Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Assignation of rent
    Creato il 22 giu 2005
    Consegnato il 11 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The companys whole right title and interest in and to the rent and all other monies due at the date of the charge and to become due in terms of the sub-lease. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited Acting as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 11 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on 27TH june 2005 and
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 11 lug 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due by an obligor to the senior finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All and whole the subjects k/a and forming holiday inn edinburgh north 107 queensferry road edinburgh lying in the county of midlothian t/n MID42893. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited Acting as Security Trustee for Itself and the Secured Parties
    Transazioni
    • 11 lug 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Mortgage
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 28 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brevi particolari
    L/H crowne plaza birmingham nec at national exhibition centre birmingham west midlands t/n WM722535 f/h crowne plaza london - heathrow at land and buildings on the west side of stockley road and the north side of cherry lane west drayton t/n NGL160680 f/h holiday inn brentwood at brook street brentwood t/n EX323558 * please refer to the form 395 for further details of property charged *. see the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited (The Security Trustee)
    Transazioni
    • 28 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 20 giu 2005
    Consegnato il 22 giu 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each obligor to the senior finance parties, the senior mezzanine finance parties and the rcf finance party (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transazioni
    • 22 giu 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 giu 2013Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0