LUMINAR IP

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàLUMINAR IP
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà privata a responsabilità illimitata
    Numero di società 04722056
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di LUMINAR IP?

    • (7499) /

    Dove si trova LUMINAR IP?

    Indirizzo della sede legale
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di LUMINAR IP?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al25 feb 2010

    Quali sono le ultime deposizioni per LUMINAR IP?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ2

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento d'ufficio

    1 pagineGAZ1

    Nomina di Mr Simon Terence Douglas come amministratore in data 14 nov 2011

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Philip Hedley Bowcock come amministratore in data 14 nov 2011

    1 pagineTM01

    Bilancio annuale redatto al 08 ago 2011 con elenco completo degli azionisti

    14 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital15 ago 2011

    Stato del capitale al 15 ago 2011

    • Capitale: GBP .99816
    SH01

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Philip Hedley Bowcock come amministratore

    2 pagineAP01

    Nomina di Mrs Jayne Fearn come segretario

    1 pagineAP03

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    Cessazione della carica di Timothy O'gorman come segretario

    1 pagineTM02

    legacy

    23 pagineMG01

    Bilancio redatto al 25 feb 2010

    11 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 08 ago 2010

    14 pagineAR01

    Cessazione della carica di Andrew Marks come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Luminar Leisure Limited come amministratore

    2 pagineAP02

    Bilancio redatto al 26 feb 2009

    15 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    8 pagine395

    legacy

    8 pagine395

    legacy

    9 pagine395

    Bilancio redatto al 28 feb 2008

    16 pagineAA

    legacy

    5 pagine363a

    legacy

    1 pagine225

    legacy

    3 pagine403a

    Bilancio consolidato redatto al 30 nov 2006

    20 pagineAA

    Chi sono gli amministratori di LUMINAR IP?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FEARN, Jayne
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Segretario
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    158774150001
    DOUGLAS, Simon Terence
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    Amministratore
    Coopers Green Lane
    AL4 9HR St. Albans
    Oak House
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish89567300002
    LUMINAR LEISURE LIMITED
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Amministratore
    Deltic Avenue
    Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Luminar House
    England
    Tipo di documento di identificazioneSEE
    Numero di registrazione03802937
    152133080001
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Segretario
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Segretario
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    British55241590004
    PARSONS, Steven Ian
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    Segretario
    13 Moreton Road South
    Round Green
    LU2 0TL Luton
    Bedfordshire
    British87152410003
    AUST, Jonathan Neale
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    Amministratore
    Lillys Cottage
    Hall Gate
    DE74 2QJ Diseworth
    Derby
    EnglandBritish160178570001
    BOWCOCK, Philip Hedley
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    Amministratore
    Luminar House
    Deltic Avenue Rooksley
    MK13 8LW Milton Keynes
    Bucks
    EnglandBritish158744440001
    BROWN, Gary
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    Amministratore
    Holly Tree House
    CV23 8AT Flecknoe
    Warwicks
    British94339190002
    BURFORD, Alistair Graham
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    Amministratore
    The Jungle
    Madingley Road, Coton
    CB23 7PH Cambridge
    EnglandBritish124289050002
    BURNS, Andrew Rae
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    Amministratore
    11 Glebe Avenue
    EN2 8NZ Enfield
    Middlesex
    EnglandBritish54722740002
    MARKS, Andrew Geoffrey
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    Amministratore
    170 Long Meadow
    Bedgrove
    HP21 7EB Aylesbury
    Bucks
    United KingdomBritish98760390001
    MCLOUGHLIN, Brendan Michael
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    Amministratore
    Dunwood Edge
    Dunwood Lane
    ST9 9QW Longsdon
    Staffs
    United KingdomBritish40530320004
    MORRIS, David Charles
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    Amministratore
    12 Victoria Street
    LU6 3BA Dunstable
    Bedfordshire
    British98815770001
    O'GORMAN, Timothy Joseph Gerard
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    Amministratore
    5 High Oaks Road
    AL8 7BJ Welwyn Garden City
    Hertfordshire
    EnglandBritish55241590004
    THOMAS, Stephen Charles
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    Amministratore
    Pavilion House
    Stockgrove Park
    LU7 0BB Heath And Reach
    Bedfordshire
    United KingdomBritish66198390006
    WILLITS, Henry Andrew
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    Amministratore
    Stable Barn Hall Farm
    Charwelton Road
    NN11 3TA Preston Capes
    Northamptonshire
    British90132600002

    LUMINAR IP ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Debenture
    Creato il 08 dic 2010
    Consegnato il 15 dic 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of mortgage property please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtrues, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transazioni
    • 15 dic 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Deed dated 20 february 2009 creating a floating charge
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking and all its assets see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking and all its assets, both present and future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed creating a floating charge
    Creato il 20 feb 2009
    Consegnato il 27 feb 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of floating charge its undertaking and all its assets both present and future see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transazioni
    • 27 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 15 ago 2007
    Consegnato il 30 ago 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due of a chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all its assets. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Lloyds Tsb Bank PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Benefit of the Securedcreditors
    Transazioni
    • 30 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Floating charge
    Creato il 16 dic 2004
    Consegnato il 22 dic 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from a chargor to any secured creditor under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    First floating charge its undertaking and all its assets, both present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transazioni
    • 22 dic 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Floating charge
    Creato il 23 lug 2004
    Consegnato il 04 ago 2004
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from any chargor to any secured creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Floating charge its undertaking and all assets present and future.
    Persone aventi diritto
    • Barclays Bank PLC as Security Trustee for the Benefit of the Secured Creditors
    Transazioni
    • 04 ago 2004Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 gen 2008Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0