DUCHAMP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàDUCHAMP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04729088
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di DUCHAMP LIMITED?

    • Commercio all'ingrosso di abbigliamento e calzature (46420) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli
    • Commercio al dettaglio di abbigliamento in negozi specializzati (47710) / Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autoveicoli e motocicli

    Dove si trova DUCHAMP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di DUCHAMP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al02 ago 2014

    Quali sono le ultime deposizioni per DUCHAMP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    25 pagineLIQ14
    YC5OWN3V

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2022

    20 pagineLIQ03
    YBBPRHT4

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2021

    20 pagineLIQ03
    YACMJHNL

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2020

    21 pagineLIQ03
    A9CT65E2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2019

    21 pagineLIQ03
    A8D1OVUQ

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2018

    22 pagineLIQ03
    A7DHYQS2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 04 lug 2017

    24 pagineLIQ03
    A6E388YA

    Notifica al Registro delle imprese della dichiarazione di disdetta

    3 pagineF10.2
    A5C4M6PS

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 7 Morris House Swainson Road London W3 7UP a The Chancery 58 Spring Gardens Manchester M2 1EW in data 01 ago 2016

    2 pagineAD01
    A5BMJVMQ

    Domanda di insolvenza

    INSOLVENCY:form 4.27 - certificate of appointment of liquidator
    1 pagineLIQ MISC
    Q5BOP0R5

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600
    A5AUH2HF

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione al 05 lug 2016

    LRESEX

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    19 pagine4.20
    A5AUH2GZ

    Cessazione della carica di Bjorg Kjartansdottir come amministratore in data 27 mag 2016

    1 pagineTM01
    X580XSTF

    Cessazione della carica di Bjorn Johannesson come amministratore in data 27 mag 2016

    1 pagineTM01
    X580XSS8

    Dettagli del direttore cambiati per John Francis Higgins il 27 mag 2016

    2 pagineCH01
    X580XSRK

    Dettagli del segretario cambiati per John Francis Higgins il 27 mag 2016

    1 pagineCH03
    X580XSSZ

    Bilancio annuale redatto al 20 feb 2016 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital25 feb 2016

    Stato del capitale al 25 feb 2016

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01
    X51GX5KX

    Bilancio redatto al 02 ago 2014

    23 pagineAA
    A4E81PTN

    Bilancio annuale redatto al 10 apr 2015 con elenco completo degli azionisti

    5 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital05 giu 2015

    Stato del capitale al 05 giu 2015

    • Capitale: GBP 1,000
    SH01
    X48XLVM3

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 7 Morris House Swainson Road London W3 7UP England a Unit 7 Morris House Swainson Road London W3 7UP in data 05 giu 2015

    1 pagineAD01
    X48XLVQB

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 1a Long Island House Warple Way Acton London W3 0RG a Unit 7 Morris House Swainson Road London W3 7UP in data 05 giu 2015

    1 pagineAD01
    X48XLUXV

    Iscrizione dell'ipoteca 047290880007, creata il 12 nov 2014

    13 pagineMR01
    X3KJVICG

    Nomina di Mr Bjorn Johannesson come amministratore in data 31 ott 2014

    2 pagineAP01
    X3JYXQER

    Chi sono gli amministratori di DUCHAMP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    HIGGINS, John Francis
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    Segretario
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    BritishDirector137254100001
    HIGGINS, John Francis
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    Amministratore
    Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    The Chancery 58
    United KingdomBritishFinance Director137254100001
    BEECH, David Andrew
    Greenways 14 Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    Segretario
    Greenways 14 Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    BritishDirector141162490001
    JACOBS, Diane
    16 East Churchfield Road
    W3 7LL London
    Segretario
    16 East Churchfield Road
    W3 7LL London
    BritishDesigner27860940002
    WITCHELL, David
    81 Lambton Road
    Raynes Park
    SW20 0LW London
    Segretario
    81 Lambton Road
    Raynes Park
    SW20 0LW London
    BritishAccountant114026690002
    QA REGISTRARS LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Segretario nominato
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018500001
    BEECH, David Andrew
    Greenways 14 Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    Amministratore
    Greenways 14 Barnes Croft
    Hilderstone
    ST15 8XU Stone
    Staffordshire
    BritishDirector141162490001
    CHEEMA, Rupinder Singh
    57 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    Amministratore
    57 Rosemary Hill Road
    B74 4HJ Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomBritishDirector107506460001
    CRAIG, Stephen
    135 South Beach
    KA10 6EH Troon
    Ayrshire
    Amministratore
    135 South Beach
    KA10 6EH Troon
    Ayrshire
    BritishDirector100962120001
    EELES, Jonathan David
    38 Beggars Lane
    ST13 8XE Leek
    Staffordshire
    Amministratore
    38 Beggars Lane
    ST13 8XE Leek
    Staffordshire
    EnglandBritishDirector90143680002
    GARDARSSON, Oskar
    Sudurlandsbraut
    108 Reykjavik
    12
    Iceland
    Amministratore
    Sudurlandsbraut
    108 Reykjavik
    12
    Iceland
    IcelandIcelandicInvestment Manager159287160001
    JACOBS, Mitchell Barry
    16 East Churchfield Road
    W3 7LL London
    Amministratore
    16 East Churchfield Road
    W3 7LL London
    EnglandBritishDesigner27860950002
    JOHANNESSON, Bjorn
    Swainson Road
    W3 7UP London
    Unit 7 Morris House
    England
    Amministratore
    Swainson Road
    W3 7UP London
    Unit 7 Morris House
    England
    IcelandIcelandicDirector192350750001
    KJARTANSDOTTIR, Bjorg
    Swainson Road
    W3 7UP London
    Unit 7 Morris House
    England
    Amministratore
    Swainson Road
    W3 7UP London
    Unit 7 Morris House
    England
    IcelandIcelanderDirector192350800001
    PSAROLIS, Marc
    Sutton Court Road
    Chiswick
    W4 4NH London
    34
    United Kingdom
    Amministratore
    Sutton Court Road
    Chiswick
    W4 4NH London
    34
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector115263620002
    QA NOMINEES LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Amministratore delegato nominato
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    900018490001

    DUCHAMP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 12 nov 2014
    Consegnato il 13 nov 2014
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Conance Limited
    Transazioni
    • 13 nov 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 31 ott 2013
    Consegnato il 14 nov 2013
    In corso
    Breve descrizione
    Notification of addition to or amendment of charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Arev Managemet Limited
    • Foldungur Ehf
    Transazioni
    • 14 nov 2013Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    Debenture
    Creato il 27 mar 2012
    Consegnato il 12 apr 2012
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Foldungur Ehf and Arev Management LTD.
    Transazioni
    • 12 apr 2012Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    All assets debenture
    Creato il 05 apr 2011
    Consegnato il 07 apr 2011
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Rbs Invoice Finance Limited
    Transazioni
    • 07 apr 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    Debenture
    Creato il 19 feb 2009
    Consegnato il 26 feb 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Persone aventi diritto
    • Kcaj LLP
    Transazioni
    • 26 feb 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 31 mar 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Rent deposit deed
    Creato il 27 nov 2008
    Consegnato il 03 dic 2008
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The company charges with full title guarantee its interest in the interest earning account in the name of the landlord (intended to hold the initial deposit of £58,750.00 and all other monies due under the rent deposit deed) see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Commerz Real Investmentgesellschaft Mbh
    Transazioni
    • 03 dic 2008Registrazione di un'ipoteca (395)
    Debenture
    Creato il 20 ago 2003
    Consegnato il 03 set 2003
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Venture Finance PLC
    Transazioni
    • 03 set 2003Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 28 apr 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    DUCHAMP LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1
    DataTipo
    19 set 2023Data prevista di scioglimento
    05 lug 2016Inizio della liquidazione
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praticante
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0