ADAPT CARE GROUP LIMITED

ADAPT CARE GROUP LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Bilanci
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Persone con controllo significativo
  • Ipoteche
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàADAPT CARE GROUP LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04730594
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di ADAPT CARE GROUP LIMITED?

    • Attività delle sedi centrali (70100) / Attività professionali, scientifiche e tecniche

    Dove si trova ADAPT CARE GROUP LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    1st Floor, Q4 The Square
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    England
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali sono gli ultimi bilanci di ADAPT CARE GROUP LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al28 feb 2021

    Quali sono le ultime deposizioni per ADAPT CARE GROUP LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario

    1 pagineGAZ2(A)

    Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario

    1 pagineGAZ1(A)

    Richiesta di cancellazione della società dal registro

    3 pagineDS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 28 feb 2021

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2021 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di micro-entità redatto al 28 feb 2020

    3 pagineAA

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2020 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 28 feb 2019

    9 pagineAA

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    legacy

    37 paginePARENT_ACC

    legacy

    3 pagineGUARANTEE2

    Nomina di Mrs Emma Louise Pearson come amministratore in data 15 gen 2020

    2 pagineAP01

    Cessazione della carica di Peter Kinsey come amministratore in data 31 gen 2020

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di Nicola Rosemary Lucy Hopkins come amministratore in data 31 dic 2019

    1 pagineTM01

    Indirizzo della sede legale modificato da Unit 6 Princeton Mews 167 -169 London Road Kingston upon Thames Surrey KT2 6PT a 1st Floor, Q4 the Square Randalls Way Leatherhead KT22 7TW in data 24 giu 2019

    1 pagineAD01

    Cessazione della carica di Nicola Hopkins come segretario in data 01 mar 2019

    1 pagineTM02

    Nomina di Mr Garry John Fitton come segretario in data 01 mar 2019

    2 pagineAP03

    Nomina di Mr Peter Kinsey come amministratore in data 01 mar 2019

    2 pagineAP01

    Nomina di Mr Garry John Fitton come amministratore in data 01 mar 2019

    2 pagineAP01

    Dichiarazione di conformità presentata il 05 feb 2019 senza aggiornamenti

    3 pagineCS01

    Esercizio contabile precedente abbreviato dal 20 mar 2019 al 28 feb 2019

    1 pagineAA01

    Bilancio di società controllata esente da revisione redatto al 16 mar 2018

    8 pagineAA

    legacy

    1 pagineAGREEMENT2

    Cessazione della carica di Carole Ann Edmond come amministratore in data 18 gen 2019

    1 pagineTM01

    Chi sono gli amministratori di ADAPT CARE GROUP LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    FITTON, Garry John
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    Segretario
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    256029400001
    FITTON, Garry John
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    EnglandBritish186021130001
    PEARSON, Emma Louise
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    United KingdomBritish259860950001
    HAWKES, Michael Gwyn
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    Segretario
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    185806980001
    HOPKINS, Nicola
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    Segretario
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    249139430001
    PASCAU, Serge
    12 Lindop Road
    WA15 9DZ Hale
    Cheshire
    Segretario
    12 Lindop Road
    WA15 9DZ Hale
    Cheshire
    British38633970001
    WEBSTER, John
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    England
    Segretario
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    England
    British46640400002
    EDMOND, Carole Ann
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    Amministratore
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    EnglandBritish226048400001
    FARRAGHER, John
    Palace Gate House Old Palace Yard
    Richmond Green
    TW9 1PB Richmond Upon Thames
    Surrey
    Amministratore
    Palace Gate House Old Palace Yard
    Richmond Green
    TW9 1PB Richmond Upon Thames
    Surrey
    EnglandBritish56379150004
    FOXALL-SMITH, Sandie Teresa
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    England
    Amministratore
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    England
    EnglandBritish124609690001
    GODDEN, John Steven
    c/o Montreux Group
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    England
    Amministratore
    c/o Montreux Group
    Portsmouth Road
    KT11 1TF Cobham
    Munro House
    Surrey
    England
    United KingdomBritish102416640001
    HAWKES, Michael Gwyn
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    England
    Amministratore
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    England
    EnglandBritish114416250001
    HOPKINS, Nicola Rosemary Lucy
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    EnglandBritish215193290001
    JACKSON, Richard Nicholas
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    Amministratore
    Princeton Mews
    167 -169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6
    Surrey
    EnglandBritish123356300002
    KINSEY, Peter
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    Amministratore
    Randalls Way
    KT22 7TW Leatherhead
    1st Floor, Q4 The Square
    England
    EnglandBritish254896410001
    WEBSTER, John
    Sandy Lane
    Kingswood
    KT20 6NQ Tadworth
    Little Garth
    Surrey
    Amministratore
    Sandy Lane
    Kingswood
    KT20 6NQ Tadworth
    Little Garth
    Surrey
    United KingdomBritish46640400003
    WRONKO, Marie
    Homeleigh 28 Middleton Road
    Crumpsall
    M8 4JX Manchester
    Amministratore
    Homeleigh 28 Middleton Road
    Crumpsall
    M8 4JX Manchester
    British54235020001

    Chi sono le persone con controllo significativo di ADAPT CARE GROUP LIMITED?

    Persone con controllo significativo
    NomeNotificato ilIndirizzoCessato
    The Regard Partnership Limited
    167 - 169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6 & 7 Princeton Mews
    England
    06 apr 2016
    167 - 169 London Road
    KT2 6PT Kingston Upon Thames
    Unit 6 & 7 Princeton Mews
    England
    No
    Forma giuridicaPrivate Company Limited By Shares
    Paese di registrazioneUk
    Autorità legaleUk Company Law
    Luogo di registrazioneUk
    Numero di registrazione03153442
    Natura del controllo
    • La persona possiede, direttamente o indirettamente, più del 75% delle azioni della società.
    • La persona detiene, direttamente o indirettamente, più del 75% dei diritti di voto nella società.

    ADAPT CARE GROUP LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    A registered charge
    Creato il 28 nov 2018
    Consegnato il 03 dic 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited
    Transazioni
    • 03 dic 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 02 mar 2018
    Consegnato il 05 mar 2018
    In corso
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • Rbc Europe Limited
    Transazioni
    • 05 mar 2018Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    A registered charge
    Creato il 26 ago 2016
    Consegnato il 02 set 2016
    Soddisfatta integralmente
    Breve descrizione
    Pursuant to the charge the company charged by way of first fixed charge all its intellectual property (although no further details are specified in the charge). Please see clause 3.1.4 of the charge.
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited as Security Agent
    Transazioni
    • 02 set 2016Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 16 gen 2018Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    A registered charge
    Creato il 29 set 2014
    Consegnato il 06 ott 2014
    Soddisfatta integralmente
    L'ipoteca flottante copre tutto:
    Contiene un'ipotesi negativa:
    Contiene un'ipoteca flottante:
    Contiene un'ipoteca fissa:
    Persone aventi diritto
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent)
    Transazioni
    • 06 ott 2014Registrazione di un'ipoteca (MR01)
    • 26 ott 2016Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 set 2011
    Consegnato il 23 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each chargor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings plant and machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Royal Bank of Scotland PLC as Security Agent
    Transazioni
    • 23 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Debenture
    Creato il 13 set 2011
    Consegnato il 20 set 2011
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    For details of property charged please refer to form MGO1. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mml Capital Partners LLP (As Security Agent and Trustee)
    Transazioni
    • 20 set 2011Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 01 ott 2014Soddisfazione di un'ipoteca (MR04)
    Composite guarantee and debenture
    Creato il 19 apr 2007
    Consegnato il 01 mag 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from each charging company or other obligor to the security trustee and the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Agent and Trustee for Itself and for Eachof the Other Secured Parties
    Transazioni
    • 01 mag 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Composite mezzanine guarantee and debenture
    Creato il 18 apr 2007
    Consegnato il 30 apr 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company and each other charging company or other obligor to the chargee and the other secured parties (or any of them under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • Mezzanine Management UK Limited (Mezzanine Security Trustee)
    Transazioni
    • 30 apr 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Charge over shares
    Creato il 20 set 2005
    Consegnato il 28 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    All the securities and their proceeds of sale, all dividends, interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Debenture
    Creato il 20 set 2005
    Consegnato il 28 set 2005
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transazioni
    • 28 set 2005Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 30 set 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0