THE TRIBAL GROUP FOUNDATION
Panoramica
| Nome della società | THE TRIBAL GROUP FOUNDATION |
|---|---|
| Stato della società | Sciolta |
| Forma giuridica | Società a responsabilità limitata per garanzia senza capitale sociale, esenzione dall'uso di 'Limited' |
| Numero di società | 04730598 |
| Giurisdizione | Inghilterra/Galles |
| Data di costituzione | |
| Data di cessazione |
Riepilogo
| Ha PSCs super sicuri | No |
|---|---|
| Ha ipoteche | Sì |
| Ha una storia di insolvenza | No |
| La sede legale è in contestazione | No |
Qual è lo scopo di THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
- Altre attività di assistenza sociale senza alloggio n.c.a. (88990) / Attività sanitarie e di assistenza sociale
Dove si trova THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Indirizzo della sede legale | Kings Orchard Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol |
|---|---|
| Indirizzo della sede legale non recapitabile | No |
Quali erano i nomi precedenti di THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Nome della società | Da | A |
|---|---|---|
| THE TRIBAL FOUNDATION | 11 apr 2003 | 11 apr 2003 |
Quali sono gli ultimi bilanci di THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Ultimi bilanci | |
|---|---|
| Ultimi bilanci redatti al | 31 dic 2017 |
Quali sono le ultime deposizioni per THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Data | Descrizione | Documento | Tipo | |
|---|---|---|---|---|
Gazzetta Ufficiale finale sciolta per scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ2(A) | ||
L'azione di cancellazione volontaria è stata sospesa | 1 pagine | SOAS(A) | ||
Prima Gazzetta Ufficiale per lo scioglimento volontario | 1 pagine | GAZ1(A) | ||
Richiesta di cancellazione della società dal registro | 4 pagine | DS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2017 | 15 pagine | AA | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2018 senza aggiornamenti | 3 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2016 | 14 pagine | AA | ||
Cessazione della carica di Kyle Mcgrath come amministratore in data 25 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Martin Cumella come amministratore in data 25 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Kyle Mcgrath come amministratore in data 25 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Richard Beveridge come amministratore in data 25 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Richard Beveridge come amministratore in data 25 apr 2017 | 1 pagine | TM01 | ||
Dichiarazione di conformità presentata il 11 apr 2017 con aggiornamenti | 4 pagine | CS01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2015 | 19 pagine | AA | ||
Nomina di Mr Mark Pickett come amministratore in data 18 lug 2016 | 2 pagine | AP01 | ||
Cessazione della carica di Stephen Derrick Breach come amministratore in data 18 lug 2016 | 1 pagine | TM01 | ||
Cessazione della carica di Keith Martin Evans come amministratore in data 31 dic 2015 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2016, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 6 pagine | AR01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2014 | 11 pagine | AA | ||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2015, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 6 pagine | AR01 | ||
Cessazione della carica di Clive Roderic Ansell come amministratore in data 30 giu 2014 | 1 pagine | TM01 | ||
Bilancio redatto al 31 dic 2013 | 11 pagine | AA | ||
Dettagli del direttore cambiati per Mr Stephen Derrick Breach il 05 giu 2014 | 2 pagine | CH01 | ||
Indirizzo della sede legale modificato da 1-4 Portland Square Bristol BS2 8RR a Kings Orchard Queen Street St. Philips Bristol BS2 0HQ in data 04 ago 2014 | 1 pagine | AD01 | ||
Bilancio annuale redatto al 11 apr 2014, non è stata fornita alcuna lista dei soci | 8 pagine | AR01 | ||
Chi sono gli amministratori di THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Nome | Nominato il | Dimissioni il | Ruolo | Indirizzo | Identificazione della società | Paese di residenza | Nazionalità | Data di nascita | Professione | Numero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PICKETT, Mark Jeremy | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard | England | British | 210493320001 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Segretario | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | British | 53398040001 | ||||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Segretario | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | 150940560001 | |||||||
| LAWTON, Simon Marcus | Segretario | 28 Henleaze Avenue BS9 4ET Bristol Avon | British | 68807890001 | ||||||
| ALEXANDER, Catherine | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 137531720001 | |||||
| ALI, Lutfur Rahman | Amministratore | 28 Battery Road SE28 0JL London | British | 107803090001 | ||||||
| ANSELL, Clive Roderic | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 297900880001 | |||||
| BENTON, Anthony Henley | Amministratore | The Leys Hoxne IP21 5BP Eye Suffolk | United Kingdom | British | 75082440001 | |||||
| BEVERIDGE, Richard | Amministratore | Barton Road LA1 4ER Lancaster 14 Lancashire United Kingdom | United Kingdom | Irish | 129927540001 | |||||
| BREACH, Stephen Derrick | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 174695940001 | |||||
| COLLINS, Helen Victoria | Amministratore | 91a Castlecroft Road Finchfield WV3 8BY Wolverhampton | United Kingdom | British | 85146140002 | |||||
| COLLINS, Richard Hawke | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 53398040001 | |||||
| CORY, Alistair | Amministratore | 142 Divinity Road OX4 1LR Oxford Oxfordshire | British | 82256690001 | ||||||
| CUMELLA, Martin | Amministratore | Wood End Lodge Poolhead Lane, Tamworth In Arden BG4 5ED Solihull West Midlands | United Kingdom | British | 71794750002 | |||||
| DAVIS, Lorraine Anne | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 155012210001 | |||||
| EVANS, Keith Martin, Dr | Amministratore | Queen Street St. Philips BS2 0HQ Bristol Kings Orchard England | England | British | 83582830002 | |||||
| FRAZER, Robert Michael | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Northern Ireland | Northern Irish | 134047440001 | |||||
| GILHEANY, Peter | Amministratore | 27 Harlescott Road SE15 3DA London | United Kingdom | British | 114194370001 | |||||
| GOOD, Martin Edward | Amministratore | 29 Fulbrooke Road CB3 9EE Cambridge | United Kingdom | British | 11362040002 | |||||
| HARRIS, Karen Fiona | Amministratore | 21 Newcombe Park Mill Hill NW7 3QN London Nw7 3qn | British | 58173890001 | ||||||
| KETTLEWELL, Andrew Michael | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Rwanda | British | 155012620001 | |||||
| LAWTON, Simon Marcus | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 68807890001 | |||||
| LUCHMUN, Samatha | Amministratore | Portland Square BS2 8RR Bristol 1-4 United Kingdom | United Kingdom | British | 154378940001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | England | British | 176044430001 | |||||
| MARTIN, Peter John | Amministratore | Vine Cottage 48 High Street RG10 8BY Wangrove Berkshire | England | British | 176044430001 | |||||
| MCGRATH, Kyle | Amministratore | 23 Millmount Road S8 9EG Sheffield | United Kingdom | British | 114191290001 | |||||
| MIDDLETON, George | Amministratore | High Close House NE41 8BL Wylam . Northumberland United Kingdom | United Kingdom | British | 129929830001 | |||||
| NOEL, Elizabeth Mary Alice | Amministratore | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | British | 95923090001 | ||||||
| PITMAN, Henry John | Amministratore | Pinbury Park Duntisbourne Rouse GL7 7LG Cirencester Gloucestershire | United Kingdom | British | 55231490005 | |||||
| RICKATSON, Caroline | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | Scotland | British | 155008870001 | |||||
| TRICKETT, Christopher | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 150933510001 | |||||
| TRIEU, Nuong | Amministratore | 87-91 Newman Street London W1T 3EY | United Kingdom | British | 154371400001 | |||||
| VISICK, Sarah Jane | Amministratore | 14 Gander Hill RH16 1QX Haywards Heath West Sussex | England | British | 122751160001 | |||||
| WYNNE-JONES, Amy Elizabeth | Amministratore | Portland Square BS2 8RR Bristol 1-4 United Kingdom | United Kingdom | British | 154371180001 |
Chi sono le persone con controllo significativo di THE TRIBAL GROUP FOUNDATION?
| Nome | Notificato il | Indirizzo | Cessato | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tribal Group Plc | 01 dic 2016 | Kings Orchard One Queen Street BS2 0HQ Bristol Kings Orchard Bristol United Kingdom | No | ||||||||||
| |||||||||||||
Natura del controllo
| |||||||||||||
THE TRIBAL GROUP FOUNDATION ha ipoteche?
| Classificazione | Date | Stato | Dettagli | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Creato il 14 giu 2007 Consegnato il 21 giu 2007 | Soddisfatta integralmente | Importo garantito All monies due or to become due from each group company to the chargee and the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brevi particolari Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Persone aventi diritto
| ||||
Transazioni
| ||||
Fonte dati
- Companies House del Regno Unito
Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari. - Licenza: CC0