EDITION HOMES LIMITED

EDITION HOMES LIMITED

  • Panoramica
  • Riepilogo
  • Scopo
  • Indirizzo
  • Denominazioni precedenti
  • Bilanci
  • Bilancio annuale
  • Deposizioni
  • Amministratori
  • Ipoteche
  • Insolvenza
  • Fonte dati
  • Panoramica

    Nome della societàEDITION HOMES LIMITED
    Stato della societàSciolta
    Forma giuridicaSocietà a responsabilità limitata
    Numero di società 04731815
    GiurisdizioneInghilterra/Galles
    Data di costituzione
    Data di cessazione

    Qual è lo scopo di EDITION HOMES LIMITED?

    • Altre locazioni e gestioni di immobili propri o in affitto (68209) / Attività immobiliari

    Dove si trova EDITION HOMES LIMITED?

    Indirizzo della sede legale
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Indirizzo della sede legale non recapitabileNo

    Quali erano i nomi precedenti di EDITION HOMES LIMITED?

    Denominazioni sociali precedenti
    Nome della societàDaA
    ROCKHILL HOMES LIMITED16 mag 200316 mag 2003
    WILLOUGHBY (430) LIMITED11 apr 200311 apr 2003

    Quali sono gli ultimi bilanci di EDITION HOMES LIMITED?

    Ultimi bilanci
    Ultimi bilanci redatti al31 mar 2013

    Qual è lo stato dell'ultimo bilancio annuale per EDITION HOMES LIMITED?

    Bilancio annuale
    Ultimo bilancio annuale

    Quali sono le ultime deposizioni per EDITION HOMES LIMITED?

    Deposizioni
    DataDescrizioneDocumentoTipo

    Gazzetta ufficiale finale sciolta a seguito di liquidazione

    1 pagineGAZ2

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 gen 2016

    9 pagine4.68

    Ritorno della riunione finale in una liquidazione volontaria dei creditori

    9 pagine4.72

    Dichiarazione dei ricevimenti e dei pagamenti dei liquidatori fino a 08 gen 2015

    10 pagine4.68

    Dichiarazione delle attività con il modulo allegato 4.19

    7 pagine4.20

    Nomina di un liquidatore volontario

    1 pagine600

    Risoluzioni

    Resolutions
    1 pagineRESOLUTIONS
    Risoluzioni
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    liquidation

    Risoluzione straordinaria per la liquidazione

    LRESEX

    Indirizzo della sede legale modificato da * C/O C/O Paul John Construction Ltd Telford Way Stephenson Industrial Estate Coalville Leicestershire LE67 3HE United Kingdom* in data 20 dic 2013

    2 pagineAD01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Nomina di un curatore o di un gestore

    4 pagineRM01

    Bilancio di esenzione totale per piccole imprese redatto al 31 mar 2013

    5 pagineAA

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2013 con elenco completo degli azionisti

    4 pagineAR01
    Deposizioni associate
    CategoriaDataDescrizioneTipo
    capital12 apr 2013

    Stato del capitale al 12 apr 2013

    • Capitale: GBP 1
    SH01

    Esercizio contabile in corso prorogato dal 30 set 2012 al 31 mar 2013

    1 pagineAA01

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 22 ott 2012

    2 pagine3.6

    Rendiconto delle entrate e delle uscite del curatore fino al 06 giu 2012

    2 pagine3.6

    legacy

    2 pagineLQ02

    Bilancio annuale redatto al 11 apr 2012 con elenco completo degli azionisti

    6 pagineAR01

    Cessazione della carica di Scott Davidson come amministratore

    1 pagineTM01

    Nomina di Mr Mark David Poulson come segretario

    2 pagineAP03

    Cessazione della carica di David Twomlow come amministratore

    1 pagineTM01

    Cessazione della carica di David Twomlow come segretario

    1 pagineTM02

    Bilancio per una piccola impresa redatto al 30 set 2011

    6 pagineAA

    Indirizzo della sede legale modificato da * 4Th Floor City Gate East Tollhouse Hill Nottingham NG1 5FS* in data 18 gen 2012

    1 pagineAD01

    legacy

    2 pagineLQ01

    legacy

    4 pagineMG02

    Chi sono gli amministratori di EDITION HOMES LIMITED?

    Amministratori
    NomeNominato ilDimissioni ilRuoloIndirizzoIdentificazione della societàPaese di residenzaNazionalitàData di nascitaProfessioneNumero
    POULSON, Mark David
    Oldfield Lane
    Rothley
    LE7 7QD Leicester
    3
    England
    Segretario
    Oldfield Lane
    Rothley
    LE7 7QD Leicester
    3
    England
    168568800001
    HENRY, John Timothy
    The Hovel
    Spinney Drive Kirby Grange
    LE9 9FG Botcheston
    Leicestershire
    Amministratore
    The Hovel
    Spinney Drive Kirby Grange
    LE9 9FG Botcheston
    Leicestershire
    EnglandBritish161954590001
    BROUDER, John Francis
    149 Scraptoft Lane
    LE5 2FF Leicester
    Leicestershire
    Segretario
    149 Scraptoft Lane
    LE5 2FF Leicester
    Leicestershire
    British16306630001
    MCEWAN, Keith
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    Segretario
    15 Sanders Road
    Quorn
    LE12 8JN Loughborough
    Leicestershire
    British9631320003
    TWOMLOW, David John
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    Segretario
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    British50893390001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Segretario nominato
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    900023630001
    BAGSHAW, Paul William Richard
    Rotherhill
    1 Church Lane Spoxton
    LE14 4PZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Rotherhill
    1 Church Lane Spoxton
    LE14 4PZ Melton Mowbray
    Leicestershire
    United KingdomBritish75614770001
    DAVIDSON, Scott Innes
    Bottom Green Farm
    Bottom Green, Upper Broughton
    LE14 3BA Melton Mowbray
    Leicestershire
    Amministratore
    Bottom Green Farm
    Bottom Green, Upper Broughton
    LE14 3BA Melton Mowbray
    Leicestershire
    EnglandBritish31525750002
    TWOMLOW, David John
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    Amministratore
    Manor Rise
    WS14 9RF Lichfield
    44
    Staffordshire
    EnglandBritish50893390001
    WOOD, Timothy John
    Magnolia Cottage
    Green Lane Off Cockshot Lane
    WR7 4JZ Dormston
    Worcestershire
    Amministratore
    Magnolia Cottage
    Green Lane Off Cockshot Lane
    WR7 4JZ Dormston
    Worcestershire
    United KingdomBritish104447140001
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    Amministratore delegato nominato
    20 Low Pavement
    NG1 7EA Nottingham
    Nottinghamshire
    900023620001

    EDITION HOMES LIMITED ha ipoteche?

    Ipoteche
    ClassificazioneDateStatoDettagli
    Legal charge
    Creato il 08 ott 2010
    Consegnato il 15 ott 2010
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the debtor to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H residential flats at hamilton fields hamilton leicester t/n LT416636 by way of fixed charge any other interest in the property, all rents receivable & all plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 15 ott 2010Registrazione di un'ipoteca (MG01)
    • 113 giu 2011Nomina di un amministratore o gestore (LQ01)
    • 125 ott 2012Avviso di cessazione delle funzioni di amministratore o gestore (LQ02)
      • Numero di pratica 1
    Legal charge
    Creato il 31 lug 2009
    Consegnato il 06 ago 2009
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property being flats VT4 four chimneys crescent hampton vale peterborough, t/no.CB339582 see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Sol Construction Limited
    Transazioni
    • 06 ago 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 02 giu 2011Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (MG02)
    Assignment of rental income
    Creato il 21 lug 2009
    Consegnato il 23 lug 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    The assets and all rights under or in relation to the rental income and all claims relating to them see image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 23 lug 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 10 giu 2009
    Consegnato il 15 giu 2009
    In corso
    Importo garantito
    £241,695 and all other monies due or to become due
    Brevi particolari
    L/H land and premises k/a flats at V2 stewartby avenue, hampton vale, petersborough t/no CB339586.
    Persone aventi diritto
    • Clegg Accomodation Solutions Limited
    Transazioni
    • 15 giu 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Deed of charge over deposit
    Creato il 09 gen 2009
    Consegnato il 14 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brevi particolari
    By way of first fixed charge the entire right, title and interest in and to all money in any currency standing to the credit of the account numbered 0631855, sort code: 12-08-81 and all rights and benefits accruing to or arising in connection with the deposit. See image for full details.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 14 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    Legal charge
    Creato il 09 gen 2009
    Consegnato il 13 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a first and second floors VT2 hampton vale peterborough fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 206 dic 2013Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 2
    Legal charge
    Creato il 09 gen 2009
    Consegnato il 13 gen 2009
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    L/H property k/a first and second floors VT4 hampton vale peterborough fixed charge all buildings & other structures fixed to the property, fixed charge any goodwill relating to the property, fixed charge all plant machinery & other items affixed to the property. Assignment of the rental sums together with the benefit of all rights & remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property. Floating charge all unattached plant machinery, chattels & goods on or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Persone aventi diritto
    • Bank of Scotland PLC
    Transazioni
    • 13 gen 2009Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 306 dic 2013Nomina di un amministratore o gestore (RM01)
      • Numero di pratica 3
    Charge of agreement for lease
    Creato il 12 ott 2007
    Consegnato il 18 ott 2007
    In corso
    Importo garantito
    All monies due or to become due from henry davidson developments limited to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement for lease dated 15 august 2007 relating to residential flats at the local centre off sandhills avenue, hamilton, leicester part t/no LT390439 and all money now and in the future due to the company pursuant to the agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 18 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    Charge of agreement for lease
    Creato il 10 ott 2007
    Consegnato il 13 ott 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from henry davidson developments LTD (the debtor) to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    An agreement for lease dated 25 july 2007 relating to residential flats at the local centre hampton vale peterborough and made between (1) the debtor) and (2) the company and all money due pursuant to the agreement.
    Persone aventi diritto
    • National Westminster Bank PLC
    Transazioni
    • 13 ott 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 04 apr 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)
    Mortgage debenture
    Creato il 15 ago 2007
    Consegnato il 25 ago 2007
    Soddisfatta integralmente
    Importo garantito
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brevi particolari
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery.
    Persone aventi diritto
    • Aib Group (UK) PLC
    Transazioni
    • 25 ago 2007Registrazione di un'ipoteca (395)
    • 07 gen 2009Dichiarazione di soddisfazione di un onere in tutto o in parte (403a)

    EDITION HOMES LIMITED ha procedimenti di insolvenza?

    Numero di praticaDateTipoProfessionistiAltro
    1Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Gregory Bill Judd
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Ricevitore/gestore
    3 Brindleyplace
    B1 2JB Birmingham
    Alistair Charles Wright
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    Ricevitore/gestore
    3 Brindley Place
    B1 2JB Birmingham
    2Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Edward Cookson
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    Ricevitore/gestore
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    R Crompton
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    Ricevitore/gestore
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    3Ricevitore/gestore nominato
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Jonathan Edward Cookson
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    Ricevitore/gestore
    12th Floor, 11 Brindley Place
    2 Brunswick Square
    B1 2LP Birmingham
    R Crompton
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    Ricevitore/gestore
    12th Floor 11 Brindleyplace 2 Brunswick Square
    Brindleyplace
    B1 2LP Birmingham
    4
    DataTipo
    09 gen 2014Inizio della liquidazione
    29 apr 2016Data di scioglimento
    Liquidazione volontaria dei creditori
    NomeRuoloIndirizzoNominato ilCessato il
    Richard Paul James Goodwin
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham
    Praticante
    79 Caroline Street
    B3 1UP Birmingham

    Fonte dati

    • Companies House del Regno Unito
      Il registro ufficiale delle imprese nel Regno Unito, che fornisce l'accesso pubblico alle informazioni sulle imprese, come nomi, indirizzi, amministratori e depositi finanziari.
    • Licenza: CC0